David Henry WILLIAMS
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | David |
Zweites Vornamen | Henry |
Nachname | WILLIAMS |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 5 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 11 |
Gesamt | 18 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB-GROUP LTD | 20. Apr. 2010 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Merus Court Meridian Business Park LE19 1RJ Leicester 5 Leicestershire | England | British | |
GELDARDS LLP | 26. Sept. 2005 | Aktiv | Mitglied der LLP | Tyndall Street CF10 4BZ Cardiff 4 Capital Quarter Wales | England | |||
EDWARDS GELDARD LIMITED | 18. Apr. 2005 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Tyndall Street CF10 4BZ Cardiff 4 Capital Quarter Wales | England | British | |
DERBY CITYSCAPE LIMITED | 11. Juni 2004 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 58 Brookside Road Breadsall Village DE21 5LF Derby Derbyshire | England | British | |
DERBY CITYSCAPE LIMITED | 30. Juni 2003 | Aufgelöst | Solicitor | Sekretär | 58 Brookside Road Breadsall Village DE21 5LF Derby Derbyshire | British | ||
KIRKWALL SECURITIES LIMITED | 19. Okt. 1999 | Aktiv | Solicitor | Sekretär | Smalley DE7 6JS Ilkeston 21 Hall Farm Way Derbyshire England | British | ||
KIRKWALL SECURITIES LIMITED | 19. Okt. 1999 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Smalley DE7 6JS Ilkeston 21 Hall Farm Way Derbyshire England | England | British | |
EMB LIMITED | 25. Juli 2006 | 09. Mai 2024 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Merus Court Meridian Business Park LE19 1RJ Leicester 5 Leicestershire United Kingdom | England | British |
NOTTINGHAM REGENERATION LIMITED | 19. Mai 2011 | 26. Apr. 2022 | Liquidation | Solicitor | Geschäftsführer | Lace Market Square NG1 1PB Nottingham 2 | England | British |
CROMFORD MILL LIMITED | 01. Apr. 2016 | 31. Aug. 2021 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Mill Road Cromford DE4 3RQ Matlock Cromford Mill Derbyshire | England | British |
ARKWRIGHT SOCIETY LIMITED(THE) | 31. Okt. 2012 | 31. Aug. 2021 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Mill Road Cromford DE4 3RQ Matlock Cromford Mill Derbyshire | England | British |
THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.10, LLP | 07. Okt. 2003 | 22. März 2021 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | 58 Brookside Road Breadsall Village DE21 5LF Derby | England | ||
GROSVENOR PARK 2005 FILM PARTNERSHIP NO.1 LLP | 22. Dez. 2004 | 21. Aug. 2020 | Aufgelöst | Mitglied der LLP | Hall Farm Way Smalley DE7 6JS Ilkeston 21 England | England | ||
FUTURE SCREEN PARTNERS NO.1 LLP | 01. Dez. 2004 | 06. Apr. 2020 | Aktiv | Mitglied der LLP | Hall Farm Way Smalley DE7 6JS Ilkeston 21 Derbyshire United Kingdom | England | ||
DC REALISATIONS 1 LIMITED | 30. Mai 2017 | 25. Sept. 2019 | In Verwaltung | Solicitor | Geschäftsführer | Pride Park DE24 8XL Derby Pride Park Stadium England | England | British |
GO DEBT LIMITED | 13. Juli 2000 | 01. Juli 2015 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Dumfries House Dumfries Place CF10 3ZF Cardiff | England | British |
THE MULTI-FAITH CENTRE AT THE UNIVERSITY OF DERBY | 03. Nov. 2009 | 12. Nov. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | c/o Geldards Llp Enterprise Way NG2 1EN Nottingham The Arc Nottinghamshire | England | British |
DERBYSHIRE FIRST INVESTMENTS LIMITED | 23. Nov. 1993 | 11. Juli 2000 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 58 Brookside Road Breadsall Village DE21 5LF Derby Derbyshire | England | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0