Colin Alexander GRANT
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Colin |
Zweites Vornamen | Alexander |
Nachname | GRANT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 11 |
Inaktiv | 4 |
Zurückgetreten | 16 |
Gesamt | 31 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A CONSULTANTS LIMITED | 07. März 2025 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | The Fairways Carrick Knowe Avenue EH12 7BX Edinburgh Flat 2/5 United Kingdom | Scotland | British | |
APS EOT LIMITED | 18. Feb. 2025 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | 2 Fairbairn Place EH54 6TN Livingston N A S House Scotland | Scotland | British | |
ALPHA DATA PARALLEL SYSTEMS EOT LIMITED | 27. Aug. 2024 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | EH12 7BX Edinburgh 2/5 Carrick Knowe Avenue | Scotland | British | |
MCROBB EOT LIMITED | 04. Jan. 2024 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Carrick Knowe Avenue EH12 7BX Edinburgh 2/5 Scotland | Scotland | British | |
R. & M. EOT TRUSTEE LIMITED | 10. Okt. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Westerton Road East Mains Industrial Estate EH52 5AU Broxburn Unit 5 United Kingdom | Scotland | British | |
R. & M. DISTRIBUTION EOT LIMITED | 31. Aug. 2022 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Carrick Knowe Avenue EH12 7BX Edinburgh 2/5 Scotland | Scotland | British | |
GREENTECH EOT LIMITED | 02. Juni 2021 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Carrick Knowe Avenue EH12 7BX Edinburgh 2/5 The Fairways Scotland | Scotland | British | |
MERLIN ERD LIMITED | 12. Feb. 2021 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House Perthshire | Scotland | British | |
CLARKSTON SERVICES LTD. | 03. Apr. 2017 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Glenwood Place G45 9UH Glasgow Unit 7e Scotland | Scotland | British | |
CSL (EOT) LIMITED | 24. März 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Glenwood Place G45 9UH Glasgow Unit 7e Scotland | Scotland | British | |
SPARICOM LIMITED | 07. Jan. 2009 | Aufgelöst | Sekretär | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | British | |||
MOTORMAX LIMITED | 16. Nov. 2007 | Aufgelöst | Business Adviser | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British | |
FIREFREEZE LIMITED | 16. Nov. 2007 | Aufgelöst | Business Adviser | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British | |
ADAPT (UK) LIMITED | 01. Nov. 2005 | Aufgelöst | Business Consultant | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British | |
TIME2ADAPT LIMITED | 01. Nov. 2005 | Liquidation | Business Consultant | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British | |
R & M ELECTRICAL WHOLESALERS EOT LTD | 22. Sept. 2022 | 03. Okt. 2022 | Aufgelöst | Financial Adviser | Geschäftsführer | Cookston Road Portlethen AB12 4PT Aberdeen The Rowans Scotland | Scotland | British |
ALLAN MURRAY ARCHITECTS LIMITED | 22. Dez. 2020 | 31. Juli 2022 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | 9 Harrison Gardens Edinburgh EH11 1SJ | Scotland | British |
HUNTSWOOD SCOTLAND LIMITED | 08. Nov. 2018 | 25. Okt. 2021 | Aktiv | Business Advisor | Geschäftsführer | Bath Street G2 2EN Glasgow 1st Floor, Tara House Scotland | Scotland | British |
MERLIN ERD LIMITED | 08. Aug. 2018 | 12. Dez. 2019 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Necessity Brae PH2 0PF Perth Merlin House Perthshire | Scotland | British |
LANGHILL LIMITED | 21. Jan. 2013 | 15. Feb. 2016 | Aufgelöst | Business Manager | Geschäftsführer | Necessity Brae PH2 0PT Perth Merlin House Scotland | Scotland | British |
CHEETAH EDUCATION SUPPLIES COMPANY LIMITED | 25. März 2013 | 07. Jan. 2014 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Cookston Road Portlethen AB12 4PT Aberdeen The Rowans Scotland Scotland | Scotland | British |
LEADING SOFTWARE LIMITED | 25. Mai 2012 | 01. März 2013 | Aktiv | Business Consultant | Geschäftsführer | Hanover Street EH2 1DJ Edinburgh 93-95 Scotland | Scotland | British |
MORAY TOURISM DEVELOPMENT | 23. Feb. 2011 | 15. Okt. 2012 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 103 High Street IV30 1EB Elgin The Tower Moray | Scotland | British |
HUNTER LOGIE LTD. | 08. Juni 2007 | 01. Jan. 2010 | Aktiv | Business Advisor | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British |
DEE VOICE & DATA LIMITED | 10. Nov. 2005 | 16. Aug. 2007 | Aufgelöst | Business Advisor | Sekretär | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | British | |
OPUS HCL LTD | 10. Juli 2001 | 05. Apr. 2002 | Aufgelöst | Director | Sekretär | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | British | |
OPUS HCL LTD | 10. Juli 2001 | 05. Apr. 2002 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British |
BLYTH & BLYTH LIMITED | 31. Jan. 2000 | 21. Dez. 2001 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British |
BLYTH & BLYTH LIMITED | 02. Juni 1997 | 21. Dez. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | British | ||
PILGRIM SYSTEMS LIMITED | 14. Okt. 1991 | 14. Okt. 1991 | Aktiv | Sekretär | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | British | ||
PILGRIM SYSTEMS LIMITED | 14. Okt. 1991 | 14. Okt. 1991 | Aktiv | Financial Director | Geschäftsführer | The Rowans Cookston Road Portlethan AB12 4PT Aberdeen | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0