Stephen Jeffrey DARLINGTON
  • Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Stephen Jeffrey DARLINGTON

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameStephen
    Zweites VornamenJeffrey
    NachnameDARLINGTON
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv5
    Zurückgetreten55
    Gesamt60

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    PEC (LIVERPOOL) LIMITED04. Apr. 2000AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    PALATINE ENGRAVING PENSION TRUSTEES LIMITED04. Apr. 2000AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    PEC (LIVERPOOL) LIMITED05. Okt. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PEC (SCOTLAND) LIMITED05. Okt. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PALATINE ENGRAVING PENSION TRUSTEES LIMITED05. Okt. 1998AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING (UK HOLDINGS) LIMITED30. Sept. 201021. Nov. 2022AufgelöstChairmanGeschäftsführer
    Woburn Road Industrial Estate, Wolseley Road
    Kempston
    MK42 7XT Bedford
    C/O Atlas Converting Equipment Limited
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING EQUIPMENT LIMITED25. Okt. 201030. Nov. 2020AktivChairmanGeschäftsführer
    Wolseley Road
    Kempston
    MK42 7XT Bedford
    United KingdomBritish
    BOBST UK & IRELAND LTD19. Mai 200831. Juli 2010AktivAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD19. Mai 200831. Juli 2010AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK & IRELAND LTD29. Feb. 200831. Juli 2010AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD29. Feb. 200831. Juli 2010AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST UK HOLDINGS LTD21. Juli 199831. Juli 2010AktivSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK HOLDINGS LTD01. Juni 199831. Juli 2010AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST UK & IRELAND LTD01. Juni 199930. Apr. 2006AktivAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD21. Juli 199830. Apr. 2006AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    LASERCOMB DIES LIMITED25. Juni 199831. Jan. 2006AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS HURLEY-MOATE LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    ATLAS HURLEY-MOATE LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS GROUP AMERICAS LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    TITAN CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AktivSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    ATLAS GROUP AMERICAS LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    TITAN CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30. Jan. 200430. Juni 2005AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST MANCHESTER LTD30. Jan. 200430. Juni 2005AktivSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK & IRELAND LTD01. Juni 199930. Juni 2005AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    OSCAR FRIEDHEIM LIMITED01. Juni 199930. Juni 2005AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    FRIEDHEIM INTERNATIONAL LIMITED19. Okt. 199830. Juni 2005AktivAccountantGeschäftsführer
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PEC (SCOTLAND) LIMITED04. Apr. 200023. Sept. 2003AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD04. Apr. 200023. Apr. 2003AufgelöstAccountantSekretär
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    SWEMKO LONDON LIMITED21. Juli 199819. März 2001AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    OSCAR FRIEDHEIM LIMITED01. Juni 199904. Apr. 2000AktivAccountantSekretär
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    LASERCOMB DIES LIMITED25. Juni 199804. Apr. 2000AktivAccountantSekretär
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    BB & EA LIMITED26. Juli 199618. Aug. 1997AufgelöstSekretär
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    CONTRACTORS' SCAFFOLDING AND FORMWORK LIMITED12. Juli 199618. Aug. 1997AufgelöstSekretär
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    00118632 LIMITED12. Juli 199618. Aug. 1997AktivDirectorGeschäftsführer
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0