• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Alan Logan TURNBULL

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAlan
    Zweites VornamenLogan
    NachnameTURNBULL
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv0
    Inaktiv1
    Zurückgetreten12
    Gesamt13

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    CASTLE COMPUTER SERVICES (UK) LIMITED13. Apr. 2018AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Regent Court
    70 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    C/O Robb Ferguson
    Scotland
    United KingdomBritish
    SOLAIS TOPCO LIMITED23. Dez. 202331. Dez. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOLAIS LIMITED23. Dez. 202331. Dez. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    C2 SOFTWARE LIMITED03. Nov. 202331. Dez. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House, 19
    Scotland
    United KingdomBritish
    CONSILIUM U.K. LIMITED02. Sept. 202231. Dez. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    KICKSECURE LTD.17. Sept. 202131. Dez. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    KICK BUSINESS SOFTWARE LIMITED05. Aug. 202131. Dez. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    KICK INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LIMITED05. Aug. 202131. Dez. 2024AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    KICK COMMS LIMITED16. Apr. 202131. Dez. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    CASTLE COMPUTER SERVICES LTD.13. Apr. 201831. Dez. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    TALON BUSINESS SOLUTIONS LIMITED30. Sept. 201731. Dez. 2024AktivDirectorGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    KICK ICT GROUP LIMITED01. Sept. 201631. Dez. 2024AktivGreat BritainGeschäftsführer
    19 Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Solais House
    Scotland
    United KingdomBritish
    TSG SCOTLAND LIMITED31. Dez. 200320. Mai 2004AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    25 Berryhill Drive
    Giffnock
    G46 7AS Glasgow
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0