• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Jason MCBURNIE

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameJason
    NachnameMCBURNIE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv2
    Inaktiv0
    Zurückgetreten71
    Gesamt73

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    CHML LIMITED28. Nov. 2023AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Solomon's View
    Dunlop
    KA3 4ES Kilmarnock
    6
    Scotland
    ScotlandBritish
    SOLOMON HOSPITALITY GROUP LIMITED19. Aug. 2022AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Chesford Grange Hotel
    CV8 2LD Kenilworth
    The Hub Building,
    Warwickshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    MACDONALD BOTLEY PARK LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    HILL VALLEY HOTEL GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    ScotlandBritish
    MACDONALD PORTLAND LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    CALLERS-LINDEN HOLDINGS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    CRAXTON WOOD DEVELOPMENTS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD HOUSTOUN HOUSE LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    CARDRONA HOTEL, GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MH APARTMENTS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    LEDGE 563 LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    BOBSLEIGH INN LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish
    PORTAL HOTEL GOLF & COUNTRY CLUB LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD GOLF LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    BEGINMAJOR LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    BOTLEY PARK GOLF CLUB LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFanance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD ALVESTON LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD AVIEMORE HIGHLAND RESORT LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    GATEWAY MANCHESTER HOTELS LTD17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD DONA LOLA NO.1 LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    GATEWAY HOLYROOD EDINBURGH LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    THAINSTONE HOUSE HOTEL LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD COMPLEAT ANGLER LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD RESORTS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD HOTELS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    AVIEMORE LEISURE MANAGEMENT LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    COUNTRYTOWN HOTELS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD KILHEY COURT LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD HOTELS MANAGEMENT SERVICES LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    GATEWAY EDINBURGH HOTELS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD TICKLED TROUT LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MDH 123 LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    MACDONALD LOCH RANNOCH LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    INTRA INNS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish
    TIMESHARE OPTIONS LIMITED17. Feb. 201731. Mai 2019AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0