• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Sharon Mary ROBERTS

    Natürliche Person

    TitelMs
    VornameSharon
    Zweites VornamenMary
    NachnameROBERTS
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv21
    Inaktiv0
    Zurückgetreten91
    Gesamt112

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    ESTEEM CARE HOLDINGS LIMITED31. Juli 2024AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10
    West Midlands
    England
    EnglandBritish
    ESTEEM CARE MANCHESTER LIMITED31. Juli 2024AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10
    West Midlands
    England
    EnglandBritish
    ESTEEM CARE LEEDS LIMITED31. Juli 2024AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10
    West Midlands
    England
    EnglandBritish
    ESTEEM CARE CUMBRIA LIMITED31. Juli 2024AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10
    West Midlands
    England
    EnglandBritish
    ESTEEM CARE DUMFRIES AND GALLOWAY LIMITED31. Juli 2024AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10
    West Midlands
    England
    EnglandBritish
    LUCERNE (SCOTLAND) LIMITED17. Juni 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Ladykirk Business Park
    11 Skye Road
    KA9 2TA Prestwick
    Heritage House
    Scotland
    EnglandBritish
    ABLE HEALTH CARE SCOTLAND LTD29. Apr. 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Ladykirk Business Park
    11 Skye Road
    KA9 2TA Prestwick
    Heritage House
    Scotland
    EnglandBritish
    DELUXE HOME CARE LTD18. März 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    Procopy Business Centre
    Parc Ty Glas
    CF14 5DU Llanishen
    2nd Floor
    Cardiff
    Wales
    EnglandBritish
    GROSVENOR HEALTH AND SOCIAL CARE LIMITED06. Jan. 2022AktivCfoGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    9
    England
    EnglandBritish
    CDA CARE LIMITED10. Dez. 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Procopy Business Centre
    Parc Ty Glas
    CF14 5DU Llanishen
    2nd Floor
    Cardiff
    Wales
    EnglandBritish
    ALLANDER HOMECARE LTD01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    Wobaston Road
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9
    England
    EnglandBritish
    ACTIVE CARE (AYRSHIRE) LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Ladykirk Business Park
    11 Skye Road
    KA9 2TA Prestwick
    Heritage House
    Scotland
    EnglandBritish
    MERIDIAN HEALTH & SOCIAL CARE LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9-10 Pendeford Place
    West Midlands
    EnglandBritish
    CARE CYMRU SERVICES LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    Wobaston Road
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9
    England
    EnglandBritish
    RAINBOW SERVICES (UK) LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Ladykirk Business Park
    11 Skye Road
    KA9 2TA Prestwick
    Heritage House
    Scotland
    EnglandBritish
    MAYFAIR HOMECARE LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    Wobaston Road
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9 Pendeford Place
    England
    EnglandBritish
    AMANDI COMPANIONS LIMITED01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9
    Uk
    United Kingdom
    EnglandBritish
    SEVACARE (UK) LIMITED01. Juni 2021AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Unit 9 Pendeford Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HD Wobaston Road
    Wolverhampton
    EnglandBritish
    BALMORAL HOMECARE LTD01. Juni 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Pendeford Business Park
    Wobaston Road
    WV9 5HD Wolverhampton
    Unit 9
    England
    EnglandBritish
    ACASA CARE LIMITED20. Apr. 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Ladykirk Business Park
    11 Skye Road
    KA9 2TA Prestwick
    Heritage House
    Scotland
    EnglandBritish
    KING EDWARD VI ACADEMY TRUST BIRMINGHAM06. März 2018AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Edgbaston Park Road
    B15 2UD Birmingham
    Foundation Office
    United Kingdom
    EnglandBritish
    FIVE RIVERS VENTURES LIMITED03. Juni 202109. Nov. 2021AktivDirectorGeschäftsführer
    Nightingale Place
    Pendeford Business Park
    WV9 5HF Wolverhampton
    6
    England
    EnglandBritish
    HORIZON EDUCATION (SOUTH LONDON) LIMITED05. Sept. 201930. Sept. 2020AktivDirectorGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish
    RANGE TOPCO LIMITED15. Aug. 201930. Sept. 2020AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish
    RANGE MIDCO 1 LIMITED15. Aug. 201930. Sept. 2020AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish
    RANGE BIDCO LIMITED15. Aug. 201930. Sept. 2020AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish
    RANGE MIDCO 2 LIMITED15. Aug. 201930. Sept. 2020AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish
    HORIZON SUPPORTED ACCOMMODATION LIMITED25. Okt. 201730. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    47a James Street
    OX4 1EU Oxford
    James House
    EnglandBritish
    HORIZON CARE LIMITED25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    12 Prospect Business Park
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HORIZON CARE AND EDUCATION SERVICES LIMITED25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HORIZON 2918 LIMITED25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    EnglandBritish
    HORIZON CARE AND EDUCATION GROUP LIMITED25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Prospect Business Park
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffs
    EnglandBritish
    EDUCARE ADOLESCENT SERVICES LIMITED25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Prospect Business Park
    Longford Road
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    Staffordshire
    EnglandBritish
    LYNSTEAD CHILDRENS SERVICES LTD25. Feb. 201530. Sept. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    12 Prospect Park Longford Road
    Staffordshire
    WS11 0LG Cannock
    Venture House
    EnglandBritish
    KING EDWARD VI HANDSWORTH SCHOOL02. Juni 201123. März 2016AufgelöstDirector Of Corporate FinanceGeschäftsführer
    B21 9AR Birmingham
    Rose Hill Road
    United Kingdom
    EnglandBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0