• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Jane Elizabeth WHITROW

    Natürliche Person

    TitelDr
    VornameJane
    Zweites VornamenElizabeth
    NachnameWHITROW
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv6
    Zurückgetreten26
    Gesamt33

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    ADRESTIA CORPORATE NOMINEE LIMITED22. Aug. 2022AufgelöstCfoGeschäftsführer
    280 Babraham Research Campus
    Babraham
    CB22 3AT Cambridge
    Moneta Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    JLJ SCIENTIFIC SERVICES LIMITED22. März 2021AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    40
    England
    United KingdomBritish
    SIOKEM LIMITED01. Aug. 2005AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    CAMBRIDGE BIOSTABILITY LIMITED01. Apr. 2005AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish
    CAMBRIDGE BIOSTABILITY LIMITED01. Apr. 2005AufgelöstChartered AccountantSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    AMJ CONSULTING LIMITED13. Juni 2002AufgelöstChartered AccountantSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    AMJ CONSULTING LIMITED13. Juni 2002AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish
    WOOLGROVE SCHOOL SPECIAL NEEDS ACADEMY01. Sept. 201315. Sept. 2020AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    40 Gun Lane
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish
    CONSILIENT LTD24. Nov. 200410. Apr. 2019AktivAccountantGeschäftsführer
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish
    THE RED RUBBER BALL FOUNDATION20. Apr. 201031. Dez. 2016AktivChartered AccountantGeschäftsführer
    Barleycroft Road
    AL8 6JX Welwyn Garden City
    39
    Hertfordshire
    United KingdomBritish
    CONSILIENT LTD16. Okt. 200318. Okt. 2013AktivSekretär
    The Moor
    The Moor Melbourn
    SG8 6ED Royston
    37
    Hertfordshire
    England
    British
    RIOTECH PHARMACEUTICALS LIMITED21. Feb. 200523. Jan. 2006AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    HUMAN FACTORS EUROPE LTD18. Feb. 200429. Juli 2005AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    MERLIN (SCOTLAND) GP LIMITED20. Sept. 200201. Juli 2004AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    VIVOGEN LIMITED17. Juli 200326. Jan. 2004AufgelöstChartered AccountantSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    RENEURON HOLDINGS LIMITED13. März 200314. Aug. 2003AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    MERLIN (SCOTLAND) GP LIMITED20. Sept. 200214. Aug. 2003AufgelöstAccountantSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    MERLIN GENERAL PARTNER III LIMITED15. Juli 200214. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    MERLIN GENERAL PARTNER III LIMITED11. Juli 200214. Aug. 2003AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish
    MERLIN MANAGING PARTNER III LIMITED10. Juli 200214. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    HUMOS INVESTMENTS LIMITED03. Dez. 200114. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    MERLIN BIOSCIENCE LIMITED03. Dez. 200114. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    MERLIN BIOSCIENCES LIMITED03. Dez. 200114. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    MERLIN BIOMED LIMITED03. Dez. 200114. Aug. 2003AufgelöstSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    EXCALIBUR FUND MANAGERS LIMITED03. Sept. 200114. Aug. 2003AufgelöstChartered AccountantSekretär
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    EXCALIBUR FUND MANAGERS LIMITED03. Sept. 200114. Aug. 2003AufgelöstChartered AccountantGeschäftsführer
    33 King Street
    St James's
    SW1Y 6RJ London
    British
    PARADIGM THERAPEUTICS LIMITED14. Apr. 200016. Okt. 2001AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    RENEURON LIMITED10. Okt. 200023. Jan. 2001AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    RENEURON (UK) LIMITED10. Okt. 200023. Jan. 2001AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    VECTURA LIMITED04. Aug. 199919. Juli 2000AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    VECTURA GROUP LIMITED22. Jan. 199919. Juli 2000AktivSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    BIOVEX LIMITED07. Dez. 199828. Juni 2000AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British
    PANTHERIX LIMITED18. Jan. 199920. Okt. 1999AufgelöstSekretär
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0