Steven Crawford HOLMES
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Steven |
Zweites Vornamen | Crawford |
Nachname | HOLMES |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 7 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 8 |
Gesamt | 17 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTER BUSINESS SERVICES LTD | 29. Aug. 2023 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Saughtonhall Drive Murrayfield EH12 5TN Edinburgh 26 United Kingdom | United Kingdom | Scottish | |
THE KALEIDOSCOPE TOWNHOUSE LTD. | 27. März 2023 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Abbey Lane Hinton Charterhouse BA2 7TB Bath Homewood United Kingdom | United Kingdom | Scottish | |
7 UPPER LANSDOWN MEWS LTD | 30. Apr. 2021 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Saughtonhall Drive EH12 5TN Edinburgh 26 Scotland | United Kingdom | Scottish | |
BISHOPSTROW HOUSE LTD | 29. März 2021 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Abbey Lane Hinton Charterhouse BA2 7TB Bath Homewood United Kingdom | United Kingdom | Scottish | |
HOMEWOOD PARK LIMITED | 15. Mai 2018 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 26 Saughtonhall Drive Murrayfield EH12 5TN Edinburgh Eh12 5tn Midlothian Scotland | United Kingdom | Scottish | |
THE KALEIDOSCOPE BIRD LIMITED | 22. März 2017 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 18 -19 Pulteney Road BA2 4EZ Bath The Bird Bath Somerset England | United Kingdom | Scottish | |
SOUTER BUSINESS CONSULTANCY LIMITED | 20. Aug. 2009 | Aufgelöst | Sekretär | 111 New Union Street CV1 2NT Coventry Union House West Midlands United Kingdom | British | |||
SOUTER BUSINESS CONSULTANCY LIMITED | 20. Aug. 2009 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 111 New Union Street CV1 2NT Coventry Union House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | Scottish | |
RTPL LIMITED | 01. Aug. 2005 | Aktiv | Accountant | Sekretär | 9 Springfield Road Linlithgow EH49 7JH West Lothian | British | ||
SCJ BUSINESS SERVICES LTD | 29. Nov. 2011 | 01. Dez. 2022 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Entry Rise BA2 5LR Bath 1 United Kingdom | Scotland | British |
NO.15 GREAT PULTENEY LTD | 23. Dez. 2015 | 11. Okt. 2019 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Entry Rise BA2 5LR Bath 1 Somerset United Kingdom | United Kingdom | British |
ABBEY HOTEL (BATH) LIMITED | 30. Juni 2015 | 01. Feb. 2018 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 1 - 3 North Parade BA1 1LF Bath Abbey Hotel Somerset | United Kingdom | British |
EIDERDOWN LIMITED | 30. Juni 2015 | 10. Juli 2017 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | North Parade BA1 1LF Bath Abbey Hotel England | United Kingdom | British |
CUBIC BLUE LIMITED | 21. Nov. 2005 | 31. Aug. 2014 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 68 - 74queen Elizabeth Avenue Hillington Park G52 4NQ Glasgow Office 36 Scotland | United Kingdom | British |
CUBIC BLUE LIMITED | 21. Nov. 2005 | 31. Aug. 2014 | Aufgelöst | Accountant | Sekretär | 68 - 74queen Elizabeth Avenue Hillington Park G52 4NQ Glasgow Office 36 Scotland | British | |
NETWORK COMPANY SECRETARIAL LIMITED | 24. Aug. 2009 | 24. Mai 2011 | Aufgelöst | Sekretär | 1 Entry Rise Combe Down BA2 5LR Bath Somerset | British | ||
NETWORK COMPANY SECRETARIAL LIMITED | 24. Aug. 2009 | 24. Mai 2011 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 1 Entry Rise Combe Down BA2 5LR Bath Somerset | United Kingdom | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0