Joyce Helen WHITE
Natürliche Person
| Titel | Ms | 
|---|---|
| Vorname | Joyce | 
| Zweites Vornamen | Helen | 
| Nachname | WHITE | 
| Geburtsdatum | |
| Ist Unternehmensleiter | Nein | 
| Ernennungen | |
| Aktiv | 1 | 
| Inaktiv | 11 | 
| Zurückgetreten | 116 | 
| Gesamt | 128 | 
Ernennungen
| Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEADOWSIDE INVESTMENTS LIMITED | 25. Aug. 2021 | Aktiv | Retired Solicitor | Geschäftsführer | Queen Victoria Drive G14 9BP  Glasgow 171 Scotland  | Scotland | British | |
| STUDENT ACCOMMODATION (PAISLEY) LIMITED | 05. Nov. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 6th Floor 145 St Vincent Street G2 5JF  Glasgow 145 Scotland  | Scotland | British | |
| MACNEWCO THREE HUNDRED AND FORTY TWO LIMITED | 05. Nov. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | |
| MACDONALD SMITH & CO. (TRUSTEE) LIMITED | 30. Juni 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephen's House 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow  | Scotland | British | |
| KELBURNE CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED | 13. Jan. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | |
| BATH STREET OFFICE SERVICES LIMITED | 31. Dez. 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 78 Carlton Place G5 8TH  Glasgow Pkf (Uk) Llp  | Scotland | British | |
| MACDONALDS SOLICITORS LIMITED | 31. Dez. 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephens House 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow  | Scotland | British | |
| ABLERANK INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 14. Juli 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | Floor 145 St Vincent Street G2 5JF  Glasgow 6th United Kingdom  | Scotland | British | |
| MACNEWCO TWO HUNDRED AND FORTY SEVEN LIMITED | 06. Juni 2008 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP  Glasgow  | Scotland | British | |
| REGENCY (KIRKINTILLOCH) LIMITED | 29. März 2008 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP  Glasgow  | Scotland | British | |
| RESCALLIDAE LIMITED | 01. Aug. 2007 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP  Glasgow  | Scotland | British | |
| NOTABLE BENEFITS LIMITED | 25. März 2002 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephens House Scotland  | Scotland | British | |
| MACDONALDS TRUSTEE SERVICES LIMITED | 30. Juni 2012 | 26. Juni 2017 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephen's House 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow  | Scotland | British | 
| MORTON FRASER NOMINEES LIMITED | 28. Jan. 2015 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL  Edinburgh 5th Floor Midlothian  | Scotland | British | 
| MORTON FRASER MACROBERTS LLP | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | 2 Lister Square EH3 9GL  Edinburgh 5th Floor Quartermile Two Midlothian  | Scotland | ||
| MFMAC SECRETARIES LIMITED | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL  Edinburgh 5th Midlothian United Kingdom  | Scotland | British | 
| MORTON FRASER DIRECTORS LIMITED | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL  Edinburgh 5th Floor Midlothian  | Scotland | British | 
| AZZURRO HOLDINGS LIMITED | 23. Feb. 2016 | 26. Feb. 2016 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 145 St Vincent Street G2 5JF  Glasgow 6th Floor Scotland  | Scotland | British | 
| THREE60 ENERGY WELLS UK HOLDINGS LIMITED | 23. Juli 2015 | 28. Aug. 2015 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 145 St Vincent Street G2 5JF  Glasgow 6th Floor Scotland  | Scotland | British | 
| AIRE-SALES HOLDINGS LIMITED | 05. Nov. 2012 | 28. Juni 2013 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Floor 145 St Vincent Street G2 5JF  Glasgow 6th United Kingdom  | Scotland | British | 
| CGD BINDER SOLUTIONS LTD | 05. Okt. 2012 | 30. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| VINYL ACQUISITIONS LIMITED | 19. Apr. 2012 | 10. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitors | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
| TANNOCHBRAE CUISINE LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| INNOVATIVE COMMS LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| EA PWDC LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| POWERTEK UTILITIES GROUP LIMITED | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| AGILE ENERGY RECOVERY LIMITED | 04. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| THE INVENIO PARTNERSHIP LTD | 04. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| MACNEWCO THREE HUNDRED AND THIRTY TWO LIMITED | 03. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St Stephen's House United Kingdom  | Scotland | British | 
| ISPOT @ INSTALEC LIMITED | 18. Aug. 2011 | 28. Sept. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
| KERR NISBET HOLDINGS LIMITED | 01. Sept. 2011 | 25. Juni 2012 | Aktiv | Solicitors | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
| J R JOHNSTON PROPERTIES (2) LIMITED | 13. Jan. 2012 | 21. Juni 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | Cow Wynd FK1 1PL  Falkirk 6/8 Stirlingshire  | Scotland | British | 
| AQURATE HANDLING LIMITED | 19. Apr. 2012 | 21. Mai 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
| HI-NRJ LIMITED | 19. Apr. 2012 | 03. Mai 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
| J.A.R. INVESTMENTS LIMITED | 13. Jan. 2012 | 19. März 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G12 4JL  Glasgow St. Stephen's House Scotland  | Scotland | British | 
Datenquelle
- UK Companies House 
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0