Joyce Helen WHITE
Natürliche Person
Titel | Ms |
---|---|
Vorname | Joyce |
Zweites Vornamen | Helen |
Nachname | WHITE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 1 |
Inaktiv | 11 |
Zurückgetreten | 116 |
Gesamt | 128 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEADOWSIDE INVESTMENTS LIMITED | 25. Aug. 2021 | Aktiv | Retired Solicitor | Geschäftsführer | Clairmont Gardens G3 7LW Glasgow 4 Scotland | Scotland | British | |
STUDENT ACCOMMODATION (PAISLEY) LIMITED | 05. Nov. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 6th Floor 145 St Vincent Street G2 5JF Glasgow 145 Scotland | Scotland | British | |
MACNEWCO THREE HUNDRED AND FORTY TWO LIMITED | 05. Nov. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British | |
MACDONALD SMITH & CO. (TRUSTEE) LIMITED | 30. Juni 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephen's House 279 Bath Street G2 4JL Glasgow | Scotland | British | |
KELBURNE CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED | 13. Jan. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British | |
BATH STREET OFFICE SERVICES LIMITED | 31. Dez. 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 78 Carlton Place G5 8TH Glasgow Pkf (Uk) Llp | Scotland | British | |
MACDONALDS SOLICITORS LIMITED | 31. Dez. 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephens House 279 Bath Street G2 4JL Glasgow | Scotland | British | |
ABLERANK INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED | 14. Juli 2010 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | Floor 145 St Vincent Street G2 5JF Glasgow 6th United Kingdom | Scotland | British | |
MACNEWCO TWO HUNDRED AND FORTY SEVEN LIMITED | 06. Juni 2008 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP Glasgow | Scotland | British | |
REGENCY (KIRKINTILLOCH) LIMITED | 29. März 2008 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP Glasgow | Scotland | British | |
RESCALLIDAE LIMITED | 01. Aug. 2007 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 171 Queen Victoria Drive Scotstonhill G14 9BP Glasgow | Scotland | British | |
NOTABLE BENEFITS LIMITED | 25. März 2002 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephens House Scotland | Scotland | British | |
MACDONALDS TRUSTEE SERVICES LIMITED | 30. Juni 2012 | 26. Juni 2017 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | St Stephen's House 279 Bath Street G2 4JL Glasgow | Scotland | British |
MORTON FRASER NOMINEES LIMITED | 28. Jan. 2015 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Midlothian | Scotland | British |
MORTON FRASER MACROBERTS LLP | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Bestelltes Mitglied der LLP | 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Quartermile Two Midlothian | Scotland | ||
MFMAC SECRETARIES LIMITED | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh 5th Midlothian United Kingdom | Scotland | British |
MORTON FRASER DIRECTORS LIMITED | 25. Feb. 2013 | 01. Mai 2017 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Midlothian | Scotland | British |
AZZURRO HOLDINGS LIMITED | 23. Feb. 2016 | 26. Feb. 2016 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 145 St Vincent Street G2 5JF Glasgow 6th Floor Scotland | Scotland | British |
FRASER ENERGY VENTURES LIMITED | 23. Juli 2015 | 28. Aug. 2015 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 145 St Vincent Street G2 5JF Glasgow 6th Floor Scotland | Scotland | British |
AIRE-SALES HOLDINGS LIMITED | 05. Nov. 2012 | 28. Juni 2013 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | Floor 145 St Vincent Street G2 5JF Glasgow 6th United Kingdom | Scotland | British |
CGD BINDER SOLUTIONS LTD | 05. Okt. 2012 | 30. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
VINYL ACQUISITIONS LIMITED | 19. Apr. 2012 | 10. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitors | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
TANNOCHBRAE CUISINE LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
POWERTEK UTILITIES GROUP LIMITED | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
AGILE ENERGY RECOVERY LIMITED | 04. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
INNOVATIVE COMMS LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
EA PWDC LTD | 28. Aug. 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
THE INVENIO PARTNERSHIP LTD | 04. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
MACNEWCO THREE HUNDRED AND THIRTY TWO LIMITED | 03. Mai 2012 | 05. Okt. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St Stephen's House United Kingdom | Scotland | British |
ISPOT @ INSTALEC LIMITED | 18. Aug. 2011 | 28. Sept. 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
KERR NISBET HOLDINGS LIMITED | 01. Sept. 2011 | 25. Juni 2012 | Aktiv | Solicitors | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
J R JOHNSTON PROPERTIES (2) LIMITED | 13. Jan. 2012 | 21. Juni 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | Cow Wynd FK1 1PL Falkirk 6/8 Stirlingshire | Scotland | British |
AQURATE HANDLING LIMITED | 19. Apr. 2012 | 21. Mai 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
HI-NRJ LIMITED | 19. Apr. 2012 | 03. Mai 2012 | Aufgelöst | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G2 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
J.A.R. INVESTMENTS LIMITED | 13. Jan. 2012 | 19. März 2012 | Aktiv | Solicitor | Geschäftsführer | 279 Bath Street G12 4JL Glasgow St. Stephen's House Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0