• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Allan John ROSS - Seite 4

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAllan
    Zweites VornamenJohn
    NachnameROSS
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv10
    Inaktiv62
    Zurückgetreten108
    Gesamt180

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    RED HAVAS LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House Hermitage Court
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    CREATIVE LYNX GROUP LTD23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS PROGRAMMATIC HUB LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    ADCITY UK LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS EHS DISCOVERY LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Phoenix Way
    Cirencester
    GL7 1RY Glos
    United KingdomBritish
    ELISA INTERACTIVE LTD23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS MEDIA LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    CREATIVE LYNX LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    45-51 WHITFIELD LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    SUPERHERO SCREEN LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    JUST HEALTH COMMUNICATIONS LTD23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    ORGANIC MARKETING LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    ARENA MEDIA LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    ARENA MEDIA HOLDINGS LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    FORWARD 1 UK LTD23. Sept. 202023. Sept. 2020AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS PEOPLE LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    CONRAN DESIGN GROUP LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    SCITERION LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    COOLER KING LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS WORLDWIDE LONDON LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS SO GROUP LTD23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    M AND C CONSULTANCY LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    GRAND UNION COMMUNICATIONS LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    IRIS LIFE COMMUNICATIONS LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS CX LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    3 Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS ENTERTAINMENT LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS SBH LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    BETC LONDON LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS HELIA LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    MARCOMMS GROUP LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS E GROUP LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    HAVAS PR UK LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    BTRME LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish
    CAKE GROUP LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Three Pancras Square
    N1C 4AG London
    The Hkx Building
    England
    United KingdomBritish
    H4B LONDON LIMITED23. Sept. 202023. Sept. 2020AktivAccountantGeschäftsführer
    Hermitage Court
    Hermitage Lane
    ME16 9NT Maidstone
    Havas House
    Kent
    England
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0