Murdo John MACKENZIE
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Murdo |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | MACKENZIE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 7 |
Zurückgetreten | 24 |
Gesamt | 31 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REACTOR TECHNOLOGIES LIMITED | 05. März 2010 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Castlecraig Business Park Springbank Road FK7 7WT Stirling Macfarlane Gray House Stirlingshire | Scotland | British | |
STOERHOUSE VENTURES (POWER) LIMITED | 07. Jan. 2008 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
NEW PARK MIDLOTHIAN LIMITED | 19. Mai 2005 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
NEW PARK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 19. März 2003 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
NEW PARK HIGHLAND LIMITED | 25. Juni 2002 | Aufgelöst | Managing Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
MIDLOTHIAN INNOVATION AND TECHNOLOGY TRUST | 31. Okt. 2001 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
BZQ MANAGEMENT LIMITED | 08. Jan. 1998 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British | |
NEWPARK ASSET MANAGEMENT LTD | 07. Mai 2013 | 16. Mai 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Ainsdale Lodge Scotland | Scotland | British |
PROJECT ROSYTH LIMITED | 14. Mai 2018 | 19. Jan. 2019 | Aufgelöst | Company Directot | Geschäftsführer | Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Ainsdale Lodge Scotland | Scotland | British |
EVERGREEN FORESTRY INVESTMENTS LIMITED | 15. Jan. 2014 | 19. Jan. 2019 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Bilston Glen Enterprise Centre 1 Dryden Road EH20 9LZ Loanhead Office 17 Midlothian Scotland | Scotland | British |
EDUK (INVESTMENTS) LTD. | 20. Juni 2006 | 19. Jan. 2019 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British |
NEW PARK PARTNERSHIP LLP | 14. Aug. 2002 | 19. Jan. 2019 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DJ West Linton | Scotland | ||
ENERDYNAMIC UK (INVESTMENTS) LIMITED | 19. Apr. 2016 | 29. Nov. 2018 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Edinburgh Technopole Milton Bridge EH26 0PJ Penicuik 7 The Technopole Centre Midlothian United Kingdom | Scotland | British |
ENERDYNAMIC UK LTD | 16. Juli 2013 | 29. Nov. 2018 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Ainsdale Lodge Peeblesshire Scotland | Scotland | British |
STOERHOUSE HIGHLANDS LTD | 13. Jan. 2009 | 12. Sept. 2017 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British |
ENERGROW LTD. | 14. Jan. 2003 | 20. Dez. 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British |
PROJECT ROSYTH LIMITED | 24. Feb. 2014 | 20. Dez. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Edinburgh Technopole Bush Estate EH26 0PJ Penicuik The Technopole Centre Midlothian Scotland | Scotland | British |
MIDLOTHIAN INNOVATION CENTRE LIMITED | 16. Mai 2003 | 20. Dez. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British |
ENERGY TECHNOLOGY CENTRE LIMITED | 01. Juli 2008 | 30. Mai 2012 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | Scotland | British |
ENERGROW LTD. | 14. Jan. 2003 | 13. Dez. 2006 | Aktiv | Sekretär | Ainsdale Lodge Linton Bank Drive EH46 7DT West Linton Borders | British | ||
MIDLOTHIAN AND EAST LOTHIAN CHAMBER OF COMMERCE | 08. Mai 1998 | 21. Aug. 2002 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
MOREDUN ANIMAL HEALTH LIMITED | 30. Nov. 1995 | 21. Feb. 2001 | Aktiv | Sekretär | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | ||
MOREDUN SCIENTIFIC LIMITED | 24. Jan. 2001 | Aktiv | Sekretär | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |||
THE MOREDUN FOUNDATION | 29. Juni 1995 | 13. Dez. 2000 | Aktiv | Sekretär | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | ||
NEW LIFE MINISTRIES | 18. Sept. 1998 | 30. Sept. 2000 | Aufgelöst | Chief Executive | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
SCOTTISH AUTISM | 05. Dez. 1994 | 02. Okt. 1998 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
PENTLANDS SCIENCE PARK LIMITED | 05. Aug. 1997 | 06. Juli 1998 | Aktiv | C.E.O. | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
MOREDUN SCIENTIFIC LIMITED | 06. Juli 1998 | Aktiv | Secretary & Treasurer | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | ||
PENTLAND HOLDINGS LIMITED | 27. März 1997 | 02. Juni 1998 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
EDINBURGH BIO-PARKS LIMITED | 22. Juli 1997 | 22. Mai 1998 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British | |
SCOTTISH AUTISM | 25. Nov. 1991 | 21. Nov. 1994 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | 110 Braid Road EH10 6AT Edinburgh Midlothian | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0