• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • Andrew Christopher BOLTER

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameAndrew
    Zweites VornamenChristopher
    NachnameBOLTER
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv17
    Zurückgetreten243
    Gesamt261

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    MAPLEGLADE LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Esg House Bretby Business Park
    Burton On Trent
    United KingdomBritish
    ATESTA GROUP LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United KingdomBritish
    INSPICIO FOOD TESTING LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    PRECISION MONITORING AND CONTROL LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road, Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    SCIENTIA FERROVIA LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    ESG EMPLOYEE SHARE SCHEME NOMINEE LIMITED22. Apr. 2014AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-Upon-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    SOIL MECHANICS LIMITED22. Apr. 2014LiquidationFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    ABLE MIX LIMITED28. März 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    DIDDIMIX LIMITED28. März 2013AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EVER 2514 LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    Tarmac Limited
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    FITZPATRICK INVESTMENT LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    Tarmac Limited
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    TARMAC (OGLC) LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EVER 2512 LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    Tarmac Limited
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EVER 2520 LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Millfields Road
    Ettingshall
    WV4 6JP Wolverhampton
    Tarmac Limited
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    J. THORNBACK & SONS (SURFACING) LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    NASH ROCKS LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    FORT BLOCKS LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    FENLAND AGGREGATES LIMITED03. Sept. 2012AufgelöstAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SOCOTEC MONITORING UK LIMITED01. März 201817. Apr. 2020AktivDirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Socotec House
    Burton-On-Trent
    England
    United KingdomBritish
    CALYX INVESTMENTS LIMITED01. März 201817. Apr. 2020AktivDirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Socotec House
    Burton-On-Trent
    England
    United KingdomBritish
    SOCOTEC UK HOLDING LIMITED03. Apr. 201717. Apr. 2020AktivChief Financial OfficerGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    INSPICIO ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-Upon-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    INSPICIO HOLDINGS LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-Upon-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    BUCKINGHAM INVESTIGATION SERVICES LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    SCIENTIFICS LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    SOCOTEC UK LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Socotec House
    Burton Upon Trent
    England
    United KingdomBritish
    ENVIRONMENTAL SCIENTIFICS GROUP HOLDINGS LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-Upon-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    SOCOTEC ASBESTOS LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AktivFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Socotec House
    Burton Upon Trent
    England
    United KingdomBritish
    4SEE LTD02. Juli 201817. Apr. 2020AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    CONSTRUCTIONFIT MONITORING LTD01. März 201817. Apr. 2020AufgelöstDirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Ashby Road
    DE15 0YZ Bretby
    Socotec House
    Burton Upon Trent
    England
    United KingdomBritish
    HENLEY WATER LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-On-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    WATERWISE TECHNOLOGY LIMITED22. Apr. 201417. Apr. 2020AufgelöstFinance DirectorGeschäftsführer
    Bretby Business Park
    Bretby
    DE15 0YZ Burton-Upon-Trent
    Socotec House
    England
    United KingdomBritish
    EBBSFLEET PROPERTY LIMITED13. Jan. 201404. Apr. 2014AktivAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    REDLAND MINERALS LIMITED13. Jan. 201404. Apr. 2014AktivAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    BLUE CIRCLE PROPERTIES LIMITED13. Jan. 201404. Apr. 2014AktivAccountantGeschäftsführer
    Bickenhill Lane
    Solihull
    B37 7BQ Birmingham
    Portland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0