Jamila Mary STONE
Natürliche Person
Titel | Ms |
---|---|
Vorname | Jamila |
Zweites Vornamen | Mary |
Nachname | STONE |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 16 |
Inaktiv | 18 |
Zurückgetreten | 10 |
Gesamt | 44 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGGLE BOOTH (FRANCHISING) LIMITED | 15. Apr. 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 08126663 - Companies House Default Address | Scotland | British | |
ECOSSE INNS LIMITED | 07. Apr. 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Hope Street G2 1PB Glasgow Suite 341 4th Floor, 93 Scotland | Scotland | British | |
EVENTASTIC LIMITED | 06. Apr. 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 09742694 - Companies House Default Address | Scotland | British | |
RAIL PLANT SERVICES LIMITED | 17. März 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 10414424 - Companies House Default Address | Scotland | British | |
FLUENT SOLUTIONS LIMITED | 10. März 2021 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Fisher Street CA3 8RH Carlisle Unit11,18 England | Scotland | British | |
788 CONSULTING LTD | 02. März 2021 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 10942876 - Companies House Default Address | Scotland | British | |
MARC BENZIMRA CONSULTANCY LTD | 26. Feb. 2021 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Fisher Street CA3 8RH Carlisle Unit 11, 18 England | Scotland | British | |
JJB DREAMS LIMITED | 19. Feb. 2021 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Fisher Street CA3 8RH Carlisle Unit 11 18 England | Scotland | British | |
PLAYNEST LIMITED | 20. Jan. 2021 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | |
CMS AIRCONDITIONING LTD | 06. Jan. 2021 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | 4385 CF14 8LH Cardiff 08633195 - Companies House Default Address | Scotland | British | |
RAILWAY CIVILS SOLUTIONS LIMITED | 26. Nov. 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Fisher Street Galleries 18 Fisher Street CA3 8RH Carlisle Unit 2 England | Scotland | British | |
PETEMART LTD | 07. Okt. 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | 20 Swan Street M4 5JW Manchester Swan Buildings England | Scotland | British | |
PRIDE COMMERCIAL INTERIORS LTD | 18. Aug. 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 93 Hope Street G2 6LD Glasgow Suite 292 3rd Floor Scotland | Scotland | British | |
LUXOUS LTD | 28. Juli 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Union Street KA21 5LL Saltcoats 1 | Scotland | British | |
ADAMS MCGILLAN & COMPANY LTD | 22. Juli 2020 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Bridge Street BT1 1LU Belfast 12-16 Bridge Street Northern Ireland | Scotland | British | |
NAIKEN & PARTNERS LTD | 14. Juli 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Swan Street M4 5JW Manchester Swan Buildings England | Scotland | British | |
FLIGHT PLUS LIMITED | 14. Juli 2020 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Fisher Street CA3 8RH Carlisle Unit 2 18 England | Scotland | British | |
WESTHILL CARPETS AND FLOORING LIMITED | 11. Feb. 2020 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Bath Street G2 4TP Glasgow 168 | Scotland | British | |
OSPREY OFFSHORE SERVICES LTD | 10. Feb. 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Third Floor 65 Bath Street G2 2BX Glasgow C/O Grainger Corporate Rescue & Recovery | Scotland | British | |
ADVANCED SIGNS LTD. | 07. Feb. 2020 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | 18 Bothwell Street G2 6NU Glasgow 2nd Floor | Scotland | British | |
INTERPRETING SOLUTIONS LIMITED | 05. Feb. 2020 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | 5th Floor, The Union Buildings, 51-59 Rose Lane NR1 1BY Norwich C/O Parker Andrews Ltd Norfolk | Scotland | British | |
TITAN N2 LIMITED | 31. Jan. 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 100 West Regent Street G2 2QD Glasgow 4/2 | Scotland | British | |
BARBOUR PROPERTIES LIMITED | 29. Jan. 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 93 Hope Street G2 6LD Glasgow 341 4th Floor Scotland | Scotland | British | |
KIBBLE GARDEN DECOR LTD | 09. Jan. 2020 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh Exchange Place | Scotland | British | |
THE LINEA CLINIC LIMITED | 16. Dez. 2019 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | |
LA SANDWICHERIE LTD | 04. Dez. 2019 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 93 Hope Street G2 6LD Glasgow 341 4th Floor Scotland | Scotland | British | |
CAMPBELL STONE MAINTENANCE LIMITED | 01. Dez. 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | PO BOX 16323 16323 G13 9EJ Glasgow PO BOX 16323 Scotland | Scotland | British | |
APPXCELL LIMITED | 23. Okt. 2019 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | |
DATAPHRAME LTD | 14. Okt. 2019 | Liquidation | Company Director | Geschäftsführer | Wenlock Road N1 7GU London 20-22 England | Scotland | British | |
BROMPTON DRINKS LIMITED | 24. März 2019 | Liquidation | Advisor | Geschäftsführer | 124 Finchley Road NW3 5JS London Regina House | Scotland | British | |
MCCANN ELECTRICAL LTD | 20. März 2019 | Aufgelöst | Advisor | Geschäftsführer | Berryknowes Road G52 2TT Glasgow 104 Scotland | Scotland | British | |
HASH CONTRACTS LIMITED | 22. Dez. 2018 | Liquidation | Advisor | Geschäftsführer | 1/1 104 Berryknowes Road G52 2TT Glasgow 1/1 104 Berryknowes Road Lanarkshire United Kingdom | Scotland | British | |
STEAKSRUS LTD | 10. Juli 2017 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Berryknows Road G52 2TT Glasgow 1/1, 104 Scotland | Scotland | British | |
E&L CONSULTANCY LTD | 30. Juni 2017 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 Scotland | Scotland | British | |
LIFESTYLE (STIRLING) LTD. | 09. Jan. 2020 | 01. Aug. 2022 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | 93 Hope Street G2 6LD Glasgow 341 4th Floor Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0