Alan Lamont BARR
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Alan |
Zweites Vornamen | Lamont |
Nachname | BARR |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 5 |
Zurückgetreten | 114 |
Gesamt | 119 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRUM CLAIMS LIMITED | 28. Feb. 2014 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British | |
THE SKWEEL | 28. Jan. 2013 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | Scotland | British | |
LYCIDAS (491) LIMITED | 02. Nov. 2009 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | Scotland | British | |
LYCIDAS (490) LIMITED | 14. Sept. 2009 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | Dunglass Avenue G2 5TQ Glasgow 2 | Scotland | British | |
BOWSCO REALISATIONS LIMITED | 28. Mai 2009 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | Dunglass Avenue G2 5TQ Glasgow 2 | Scotland | British | |
QUARTZTEC HOLDINGS LIMITED | 16. Juni 2015 | 17. Sept. 2015 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | c/o Wright Johnston & Mackenzie Llp St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland | Scotland | British |
LYCIDAS NOMINEES LIMITED | 23. März 1988 | 28. Aug. 2015 | Aktiv | Legal Executive | Geschäftsführer | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British |
MCCLURES LIMITED | 30. Nov. 2009 | 28. Aug. 2015 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | 292 St Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British |
LYCIDAS SECRETARIES LIMITED | 23. März 1988 | 28. Aug. 2015 | Aufgelöst | Legal Executive | Geschäftsführer | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British |
NORTH COAST 500 LIMITED | 30. Apr. 2015 | 03. Juni 2015 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
ST. VINCENT STREET (525) LIMITED | 14. März 2013 | 10. März 2014 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
FORTH CARE LIMITED | 15. Nov. 2013 | 15. Nov. 2013 | Liquidation | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
PROTECTIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 26. Juli 2013 | 14. Aug. 2013 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | Scotland | British |
GSASA LIMITED | 11. Jan. 2013 | 01. Juli 2013 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | Renfrew Street G3 6RQ Glasgow 167 Scotland | Scotland | British |
PIG IN A POKE HOLDINGS LIMITED | 23. Jan. 2013 | 23. Jan. 2013 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
MEDICS NETWORK LIMITED | 11. Dez. 2012 | 08. Jan. 2013 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
ST. VINCENT STREET (521) LIMITED | 08. Dez. 2011 | 10. Dez. 2012 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
SCOT SHERIDAN (BATH STREET) LIMITED | 08. Nov. 2012 | 08. Nov. 2012 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
PINEFIELD TRUSTEES LIMITED | 07. Nov. 2011 | 08. Nov. 2012 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom | Scotland | British |
WEST END CARE LIMITED | 07. Sept. 2012 | 27. Sept. 2012 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom | Scotland | British |
SOLAS ENERGY SAVING SERVICES LIMITED | 24. Aug. 2011 | 04. Sept. 2012 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
SCORE DIAGNOSTICS LIMITED | 24. Aug. 2012 | 24. Aug. 2012 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | Engineering Works AB42 0YX Peterhead Glenugie Aberdeenshire Scotland | Scotland | British |
COLUMBUS LEGAL LIMITED | 23. Mai 2012 | 03. Aug. 2012 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
GOOD EGG ENERGY LIMITED | 06. Dez. 2011 | 01. Juni 2012 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | 41 Bonhill Road G82 2DL Dumbarton Westonlea House Scotland | Scotland | British |
CHANCERY NOMINEES (KILNCRAIGS) LIMITED | 31. Aug. 2010 | 20. Dez. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | Scotland | British |
ASHGILL CARE HOME LIMITED | 14. Nov. 2011 | 14. Dez. 2011 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
TANNOY COMMERCIAL LIMITED | 10. Nov. 2011 | 10. Nov. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
G4 LAW ASSIST LIMITED | 03. Nov. 2010 | 03. Nov. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
NEATEBOX LIMITED | 25. Okt. 2011 | 25. Okt. 2011 | Aktiv | Executive | Geschäftsführer | Station Road EH25 9LR Roslin 20a Midlothian Scotland | Scotland | British |
SCB 2011 LIMITED | 17. Okt. 2011 | 20. Okt. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
NAPIER CAPITAL NO.3 SCOTTISH GENERAL PARTNER LIMITED | 21. Okt. 2010 | 20. Okt. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
NAPIER CAPITAL NO.3 SCOTTISH LIMITED PARTNER LIMITED | 21. Okt. 2010 | 20. Okt. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
SOLAS UTILITY INITIATIVE LIMITED | 26. Juli 2011 | 11. Okt. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 United Kingdom | Scotland | British |
SOLAS RENEWABLE ENERGY LIMITED | 24. Aug. 2011 | 29. Sept. 2011 | Aufgelöst | British | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
SOLAS PROPERTY LIMITED | 23. Aug. 2011 | 07. Sept. 2011 | Aufgelöst | Executive | Geschäftsführer | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0