• Daten
  • Großbritannien
  • Unternehmen
  • Unternehmen suchen
  • Sanktionen
  • Sanktionen suchen
  • David ROSE

    Natürliche Person

    TitelMr
    VornameDavid
    NachnameROSE
    Geburtsdatum
    Ist UnternehmensleiterNein
    Ernennungen
    Aktiv1
    Inaktiv0
    Zurückgetreten28
    Gesamt29

    Ernennungen

    Ernannte Beamte
    Ernannt zuErnennungsdatumRücktrittsdatumUnternehmensstatusBerufRolleAdresseWohnlandNationalität
    BUNWELL CONSULTANTS LIMITED25. Juni 2019AktivDirectorGeschäftsführer
    The Close
    NR1 4DJ Norwich
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    NPH HEALTHCARE (INTERMEDIATE) LIMITED07. Jan. 201505. Juli 2022AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor, South Building
    England
    United KingdomBritish
    NPH HEALTHCARE LIMITED13. Nov. 201405. Juli 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor, South Building
    England
    United KingdomBritish
    NPH HEALTHCARE (HOLDINGS) LIMITED12. Nov. 201405. Juli 2022AktivDirectorGeschäftsführer
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor, South Building
    England
    United KingdomBritish
    HUB SW DALBEATTIE HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW NHSL HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW QMA DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW GREENFAULDS HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW GREENFAULDS SUB HUB CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCommercial DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW AYR DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House,Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW LARGS HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW CUMBERNAULD HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW LARGS DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW EALC HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW CUMBERNAULD DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    ALLIANCE COMMUNITY PARTNERSHIP LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW AYR HOLDCO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW EALC DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SOUTH WEST SCOTLAND LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    HUB SW QMA HOLD CO LIMITED18. Mai 201801. Apr. 2020AktivCompany DirectorGeschäftsführer
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish
    CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED20. Jan. 201011. Nov. 2015AktivDirectorGeschäftsführer
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    United KingdomBritish
    DERBYSHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LTD09. Juli 200911. Nov. 2015AktivDirectorGeschäftsführer
    Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    10-11
    England
    United KingdomBritish
    S4B (ISSUER) PLC14. Mai 201328. Feb. 2014AktivEngineerGeschäftsführer
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    S4B (HOLDINGS) LIMITED17. Apr. 201328. Feb. 2014AktivEngineerGeschäftsführer
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    S4B LIMITED17. Apr. 201328. Feb. 2014AktivEngineerGeschäftsführer
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    United KingdomBritish
    EQUITIX EDUCATION (CAMBRIDGESHIRE) HOLDINGS LIMITED20. Jan. 201013. Mai 2010AktivDirectorGeschäftsführer
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91-93
    United KingdomBritish
    EQUITIX EDUCATION (CAMBRIDGESHIRE) LIMITED20. Jan. 201013. Mai 2010AktivDirectorGeschäftsführer
    Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House 91-93
    United KingdomBritish

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0