Christopher John BARRATT
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Christopher |
Zweites Vornamen | John |
Nachname | BARRATT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 11 |
Inaktiv | 9 |
Zurückgetreten | 15 |
Gesamt | 35 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLIC POLICY PROJECTS LTD | 11. Nov. 2024 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | |
CEJLO LIMITED | 03. Juni 2024 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | |
DORSON TRANSFORM LTD | 01. Sept. 2020 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
VIVA 2023 LTD | 01. Sept. 2020 | Freiwillige Vereinbarung | Chartered Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
AXIOM MANUFACTURING LTD | 17. Apr. 2019 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 25 Lower High Street OX18 4RN Burford Warwick House Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
ORBITSOUND UK LIMITED | 04. Jan. 2019 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
AXIOM DISPLAYS LIMITED | 30. Nov. 2017 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | St James Road NN5 5LF Northampton 100 | England | British | |
AXIOM MARKETING SERVICES LIMITED | 30. Nov. 2017 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 160 Midsummer Boulevard MK9 1FF Milton Keynes The Pinnacle | England | British | |
EAST ROAD FINANCE LIMITED | 09. März 2017 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
EAST ROAD SUPPLY LIMITED | 09. März 2017 | Liquidation | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
ORBITSOUND INTERNATIONAL LIMITED | 24. Nov. 2016 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
ECO FRIENDLY RESOURCES LTD | 01. Aug. 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Gorwell OX49 5QE Watlington 14 Oxfordshire England | England | British | |
EPANEL LIMITED | 22. Feb. 2016 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | OX49 5QE Watlington 14 Gorwell Oxfordshire England | England | British | |
ORBITSOUND LIMITED | 08. Dez. 2014 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British | |
ALTIS PROJECTS LTD | 01. Mai 2014 | Aufgelöst | Corporate Finance Advisor | Geschäftsführer | 13-15 Regent Street NG1 5BS Nottingham Church House | England | British | |
CARMIRA SERVICES LIMITED | 18. März 2014 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | Gorwell OX49 5QE Watlington 14 Oxfordshire England | England | British | |
AXIOM POP LTD | 03. Dez. 2013 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Gorwell OX49 5QE Watlington 14 Oxfordshire England | England | British | |
CHIP HOLDINGS LIMITED | 01. Feb. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British | |
FRANK GUY AIRCRAFT INTERIORS LIMITED | 16. Jan. 2006 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British | |
BARRATT CONSULTING & CORPORATE FINANCE LIMITED | 09. Juni 1995 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British | |
ACERCOR LTD | 23. Aug. 2018 | 16. Sept. 2019 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Primsdown Oxon England | England | British |
SMETHWICK DROP FORGE RECYCLING LTD | 23. Juni 2015 | 17. Sept. 2015 | Aufgelöst | Consultant | Geschäftsführer | Rd DY11 7QL Kidderminster Stourport Worcestershire | England | British |
AXIOM POP LTD | 31. Jan. 2014 | 31. Jan. 2014 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | Vincent Square SW1P 2PN London 1 United Kingdom | England | British |
INKORPORATE LIMITED | 03. Mai 2007 | 15. Feb. 2013 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 1-13 Adler Street E1 1EG London Unit 26 United Kingdom | England | British |
THE BRUNEL BUSINESS PARK (NO 1) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 26. Feb. 2007 | 15. Aug. 2012 | Aktiv | Finance Director | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British |
CENTRE DESIGN LIMITED | 16. Aug. 2007 | 20. Dez. 2010 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British |
VIEWCAST LIMITED | 18. Okt. 2002 | 05. Nov. 2008 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British | ||
BABEL MEDIA LIMITED | 02. März 2001 | 19. Juni 2008 | Aktiv | Chartered Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British |
P.T.S. SECURITY LIMITED | 26. Okt. 1999 | 31. Jan. 2008 | Aufgelöst | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | England | British |
EDDINGTONS LIMITED | 01. Jan. 2001 | 11. Apr. 2002 | Aktiv | Sekretär | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British | ||
EDDINGTONS LIMITED | 02. Nov. 2000 | 11. Apr. 2002 | Aktiv | Accountant | Geschäftsführer | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British | |
IT AGENT LIMITED | 20. Sept. 2000 | 04. Okt. 2001 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British | ||
POLARISE SYSTEMS LIMITED | 26. Mai 2000 | 20. Nov. 2000 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British | ||
PEAK TECHNOLOGIES LTD | 22. Jan. 1999 | 22. März 2000 | Aktiv | Sekretär | 1 Conduit Street W1R 9TG London | British | ||
VIEWCAST LIMITED | 20. Okt. 1999 | 01. Feb. 2000 | Aufgelöst | Sekretär | 14 Gorwell OX49 5QE Watlington Oxfordshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0