Steven JOHNSON
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Steven |
Nachname | JOHNSON |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 2 |
Inaktiv | 2 |
Zurückgetreten | 15 |
Gesamt | 19 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STREET (UK) FOUNDATION | 29. Aug. 2014 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | 14 Waterloo Street B2 5TX Birmingham Neville House West Midlands England | England | British | |
DIRECT DEBT LINE | 20. Jan. 2014 | Aufgelöst | Charity Chief Executive | Geschäftsführer | Toynbee Hall 28 Commercial Street E1 6LS London 1st Floor Sunley House Annex England | England | British | |
SCHOOL FOR SOCIAL ENTREPRENEURS | 07. Sept. 2007 | Aktiv | Charity Manager | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British | |
INDEPENDENT ADVICE SERVICES LIMITED | 04. Apr. 2005 | Aufgelöst | Charity Chief Executive | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British | |
ADVANCED CASE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | 02. Feb. 2011 | 01. Apr. 2024 | Aktiv | Manager/Charity Chief Executive | Geschäftsführer | Merchants House 7 West George Street G2 1BA Glasgow C/O Tc Young Llp | England | British |
ADVICE UK | 11. Juni 1998 | 28. Sept. 2023 | Aktiv | Manager | Sekretär | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | British | |
STREET (UK) C.I.C. | 14. Sept. 2015 | 12. Jan. 2022 | Liquidation | Chief Executive | Geschäftsführer | 14 Waterloo Street B2 5TX Birmingham Neville House West Midlands England | England | British |
STREET (UK) SERVICES LIMITED | 14. Sept. 2015 | 12. Jan. 2022 | Liquidation | Chief Executive | Geschäftsführer | 14 Waterloo Street B2 5TX Birmingham Neville House West Midlands England | England | British |
STREET UK HOMES LIMITED | 14. Sept. 2015 | 12. Jan. 2022 | Liquidation | Chief Executive | Geschäftsführer | 14 Waterloo Street B2 5TX Birmingham Neville House West Midlands England | England | British |
THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION | 15. Sept. 2009 | 02. Juni 2020 | Aktiv | Charity Chief Executive | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British |
THE ADVICE SERVICES ALLIANCE | 26. März 1998 | 25. März 2020 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | c/o Lindsey Poole Tavistock Square 1-6 Tavistock Square WC1H 9NA London Tavis House England | England | British |
SOLICITORS PRO BONO GROUP | 20. Juli 2011 | 10. Okt. 2019 | Aktiv | Chief Executive | Geschäftsführer | Gourock Road SE9 1JA London 31 England | England | British |
SOUTHERN SPACE LIMITED | 30. Juni 2014 | 21. Apr. 2017 | Aktiv | Charity Chief Executive | Geschäftsführer | Fleet House 59-61 Clerkenwell Road EC1M 5LA London | England | British |
CHANGE ACCOUNT LIMITED | 17. Dez. 2013 | 11. Apr. 2016 | Liquidation | Ceo | Geschäftsführer | Cliveland Street B19 3SH Birmingham 50 England | England | British |
THE CHANGE ACCOUNT PARTNERSHIP LLP | 27. Nov. 2013 | 28. Nov. 2013 | Aufgelöst | Bestelltes Mitglied der LLP | Regent Place Hockley B1 3NJ Birmingham 12-14 West Midlands United Kingdom | England | ||
SOLICITORS PRO BONO GROUP | 19. Mai 2004 | 14. Juli 2010 | Aktiv | Charity Director | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British |
HOMELESS LINK | 12. Dez. 2002 | 11. Dez. 2008 | Aktiv | Charity Director | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British |
AMBLECOTE CLOSE RESIDENTS COMPANY LIMITED | 13. Mai 2003 | 15. Aug. 2008 | Aktiv | Charity Director | Geschäftsführer | 31 Gourock Road Eltham SE9 1JA London | England | British |
ADVISING COMMUNITIES | 04. Dez. 1997 | 05. Feb. 1998 | Aufgelöst | Company Director | Geschäftsführer | 9 Elibank Road Eltham SE9 1QQ London | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0