John Stuart RUSSELL
Natürliche Person
Titel | |
---|---|
Vorname | John |
Zweites Vornamen | Stuart |
Nachname | RUSSELL |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 0 |
Inaktiv | 0 |
Zurückgetreten | 122 |
Gesamt | 122 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS POZNAN LIMITED | 19. Aug. 1998 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
NORPACK SERVICES LIMITED | 10. Juni 1998 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
HAMELIN PAPERBRANDS LIMITED | 10. Apr. 1997 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
BIBER PAPER CONVERTING LIMITED | 17. Aug. 1996 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
JDS HOLDING | 17. Aug. 1996 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DSS EASTERN EUROPE LIMITED | 18. März 1996 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
WADDINGTON & DUVAL LIMITED | 17. Juli 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
UNITED SHOPPER MARKETING LIMITED | 17. Juli 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
CORRUPLAST LIMITED | 17. Juli 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DSS PACKAGING SYSTEMS LIMITED | 17. Juli 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DS SMITH LOGISTICS LIMITED | 17. Juli 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ST. REGIS KEMSLEY LIMITED | 16. März 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DS SMITH PAPER LIMITED | 06. Feb. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
CALARA HOLDING LIMITED | 27. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
D.W. PLASTICS (UK) LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ST. REGIS PAPER COMPANY LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
CARLISLE PRINTERS LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DAVID S. SMITH PLASTICS LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
AVONBANK PAPER DISPOSAL LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
CONEW LIMITED | 19. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
TREFOREST MILL PLC | 18. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DANIELS(CAM)LIMITED | 18. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ST. REGIS PENSION TRUSTEES LIMITED | 18. Jan. 1995 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DSSH NO.1 LIMITED | 19. Juli 1994 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ASHTON CORRUGATED | 05. Juli 1994 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ASHTON CORRUGATED (MIDLANDS) LIMITED | 05. Juli 1994 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ASHTON CORRUGATED (SOUTHERN) LIMITED | 05. Juli 1994 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
SPACE AGE OFFICE LIMITED | 29. Apr. 1994 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DS SMITH CALARA LIMITED | 23. Juli 1993 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
SPICERS LIMITED | 23. Juli 1993 | 31. Dez. 2000 | Liquidation | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DAVID S SMITH PACKAGING (POLAND) LIMITED | 27. Apr. 1993 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED | 15. Nov. 1991 | 31. Dez. 2000 | Aktiv | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
ST REGIS PACKAGING (SCOTLAND) LIMITED | 30. Apr. 1990 | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British | |
DSS FLEXIBLES LTD | 31. Dez. 2000 | Aufgelöst | Company Secretary | Geschäftsführer | Little Pennys 70 High Wych Road CM21 0HG Sawbridgeworth Hertfordshire | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0