Darren George MCDERMOTT
Natürliche Person
Titel | Mr |
---|---|
Vorname | Darren |
Zweites Vornamen | George |
Nachname | MCDERMOTT |
Geburtsdatum | |
Ist Unternehmensleiter | Nein |
Ernennungen | |
Aktiv | 27 |
Inaktiv | 8 |
Zurückgetreten | 3 |
Gesamt | 38 |
Ernennungen
Ernannt zu | Ernennungsdatum | Rücktrittsdatum | Unternehmensstatus | Beruf | Rolle | Adresse | Wohnland | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE BUNKER GROUP LTD. | 15. Juli 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
THE BRAND BUNKER LTD | 19. Mai 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
SLOANE PRIVATE CLIENTS LTD | 28. Apr. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Quinn Close CV3 4LH Coventry The Bunker England | Scotland | British | |
BOREHAM MOTORWORKS LIMITED | 28. Apr. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Millennium Way Aycliffe Business Park DL5 6AR Newton Aycliffe Sovereign House England | Scotland | British | |
THE WATCH BUNKER LTD | 28. Apr. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Quinn Close CV3 4LH Coventry The Bunker England | Scotland | British | |
THE PRODUCTION BUNKER LTD. | 28. Apr. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Quinn Close CV3 4LH Coventry The Bunker England | Scotland | British | |
THE COFFEE BUNKER LTD. | 06. Feb. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
JE MOTORWORKS LTD | 28. Jan. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
DRVN AUTOMOTIVE LTD | 28. Jan. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
PEAK ANALOGUE LTD | 27. Jan. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
AUTO BUNKER LTD. | 27. Jan. 2020 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
EVOLUTION E-TYPES LTD | 11. Dez. 2019 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG CAPITAL 2 LIMITED | 19. Mai 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG CAPITAL 3 LIMITED | 19. Mai 2017 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG INVESTMENTS LTD. | 25. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG CHAMELEON LTD. | 25. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG CAPITAL 1 LIMITED | 25. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
MDG CAPITAL LIMITED | 25. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
CHAMELEON DIGITIZATION LIMITED | 25. Mai 2016 | Aktiv | Company Director | Geschäftsführer | Inveralmond Place Inveralmond Industrial Estate PH1 3TS Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
DEVINE ENERGY LIMITED | 08. Okt. 2015 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Pentland Industrial Estate EH20 9QH Loanhead Pentland House Mid Lothian Scotland | Scotland | British | |
DEVINE ENERGY (SCOTLAND) LTD. | 16. Sept. 2015 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | Melville Street FK1 1HZ Falkirk 2 Stirlingshire Scotland | Scotland | British | |
HIGHLAND BIOMASS SOLUTIONS LTD. | 24. Dez. 2012 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | Melville Street FK1 1HZ Falkirk 2 Stirlingshire Scotland | Scotland | British | |
BIO-FLAME BOILERS LTD | 24. Dez. 2012 | Aufgelöst | Business Executive | Geschäftsführer | Inveralmond Place Inveralmond Industrial Estate PH1 3TS Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
EASY HEAT SYSTEMS (SCOTLAND) LIMITED | 28. Sept. 2012 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
THE RECRUITMENT BUNKER LTD | 02. Juli 2012 | Aktiv | Business Executive | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
CHAMELEON VISION LIMITED | 14. Okt. 2010 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
CALEDONIA PR LTD. | 01. Dez. 2006 | Aufgelöst | Sekretär | Lindores PH5 2AS Muthill Perthshire | British | |||
CALEDONIA PR LTD. | 01. Dez. 2006 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Lindores PH5 2AS Muthill Perthshire | Scotland | British | |
THE ANGUS PLUMBING COMPANY LTD. | 04. Juli 2001 | Aufgelöst | Director | Sekretär | Lindores PH5 2AS Muthill Perthshire | British | ||
THE ANGUS PLUMBING COMPANY LTD. | 04. Juli 2001 | Aufgelöst | Director | Geschäftsführer | Lindores PH5 2AS Muthill Perthshire | Scotland | British | |
MCDERMOTT GROUP LIMITED | 01. Mai 2001 | Aktiv | Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British | |
EASY HEAT SYSTEMS (SCOTLAND) LIMITED | 17. Aug. 1999 | Aktiv | Sekretär | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | British | |||
MCDERMOTT GROUP LIMITED | 17. Aug. 1999 | Aktiv | Sekretär | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | British | |||
EASY HEAT (SCOTLAND) LIMITED | 17. Aug. 1999 | Aufgelöst | Sekretär | Lindores PH5 2AS Muthill Perthshire | British | |||
EASY HEAT SYSTEMS LIMITED | 09. Dez. 1998 | Aktiv | Managing Director | Geschäftsführer | Tweed Place PH1 1TJ Perth Mcdermott House Scotland | Scotland | British |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0