BAGIR (U.K.) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBAGIR (U.K.) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00393546
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BAGIR (U.K.) LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra BAGIR (U.K.) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit J209, The Biscuit Factory
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BAGIR (U.K.) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    J.S. RAPAPORT & COMPANY LIMITED 01 mar 194501 mar 1945

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BAGIR (U.K.) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BAGIR (U.K.) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Samuel Vlodinger como director el 16 feb 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 ago 2016

    Estado de capital el 01 ago 2016

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Units 13-15 Deane House Studios Greenwood Place Highgate Road Kentish Town London NW5 1LB a Unit J209, the Biscuit Factory 100 Clements Road London SE16 4DG el 01 ago 2016

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Daniel Shalom Taragan como director el 01 nov 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 ago 2015

    Estado de capital el 11 ago 2015

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Cese del nombramiento de Neville Critoph como secretario el 10 jul 2015

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    21 páginasAA

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neville Critoph como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Robin Harrison como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 29 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jul 2013

    Estado de capital el 30 jul 2013

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Moshe Gadot Giradi como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mr Robin Harrison como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Shlomo Moran como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de BAGIR (U.K.) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COHEN, Yehuda
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    Director
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    IsraelIsraeli169331200001
    MANNING, Craig
    44 Brightfield Road
    Lee Green
    SE12 8QF London
    Director
    44 Brightfield Road
    Lee Green
    SE12 8QF London
    United KingdomBritish107074510001
    BLATT, Eliezer Leo
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Secretario
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Israeli31826280001
    CRITOPH, Neville
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    Secretario
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    180879450001
    FACKEY, Brian Arthur
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    Secretario
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    British9935990001
    HARRISON, Robin
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    Secretario
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    171659750001
    HARRISON, Robin
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Secretario
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British16332500001
    LEWIS, David John
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    Secretario
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    British15641380006
    MELLOTTE, Joseph Thomas
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Secretario
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Irish14873920001
    MORAN, Shlomo
    Jabotinsky
    70700 Gedera
    15
    Israel
    Secretario
    Jabotinsky
    70700 Gedera
    15
    Israel
    Israeli130425510001
    ROTH, Ilan
    25 Hagalil Street
    Kfar Sava
    Israel
    Secretario
    25 Hagalil Street
    Kfar Sava
    Israel
    British78138620001
    ABRAMOVITCH, Doron
    8b Hazait Street Neva Yehuda
    Rehovot
    Israel
    Director
    8b Hazait Street Neva Yehuda
    Rehovot
    Israel
    IsraelIsraeli114357690001
    BLATT, Eliezer Leo
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Director
    27 Old Hall Road
    M7 4JJ Salford
    Lancashire
    Israeli31826280001
    BROWN, Mordechai
    PO BOX 187
    Kiryat Gat 82100
    Israel
    Director
    PO BOX 187
    Kiryat Gat 82100
    Israel
    Israeli40071100001
    FACKEY, Brian Arthur
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    Director
    10 Tarn Brow
    Aughton
    L39 4SS Ormskirk
    Lancashire
    British9935990001
    GADOT GIRADI, Moshe
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    Director
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    IsraelIsraeli161024710001
    GILBOA, Offer
    Ramot Hashavim
    FOREIGN Beit Ha'Am 13
    Israel
    Director
    Ramot Hashavim
    FOREIGN Beit Ha'Am 13
    Israel
    IsraelIsraeli68581430002
    HARRISON, Robin
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Director
    17 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British16332500001
    LANDAU, Schmuel
    19 Hibner Street
    Petach Tikva
    49400 Israel
    Director
    19 Hibner Street
    Petach Tikva
    49400 Israel
    Israeli71013940001
    LANGLEIB, Moshe
    Pob 187
    Kiryat Gat 82100
    FOREIGN
    Israel
    Director
    Pob 187
    Kiryat Gat 82100
    FOREIGN
    Israel
    Israeli14873910001
    LEWIS, David John
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    Director
    The Farthings
    83 Castle Green Westbrook
    WA5 5XB Warrington
    Cheshire
    British15641380006
    MELLOTTE, Joseph Thomas
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Director
    34 St Crispins Close
    Hampstead
    NW3 2QF London
    Irish14873920001
    NEWTON, John
    31 Gloucester Avenue
    Primrose Hill
    NW1 7AU London
    Director
    31 Gloucester Avenue
    Primrose Hill
    NW1 7AU London
    British107075910001
    PATRON, Gershon
    PO BOX 1877
    Kiryat Gat82100
    Israel
    Director
    PO BOX 1877
    Kiryat Gat82100
    Israel
    Israeli37125540001
    RONEN, Micha
    Golani 82
    Kfar Yona
    Israel
    Director
    Golani 82
    Kfar Yona
    Israel
    Israeli96878320001
    SADOT, Shmuel
    60 Levin Epstein Str
    Rehovot
    Israel
    Director
    60 Levin Epstein Str
    Rehovot
    Israel
    Israeli44039540001
    TARAGAN, Daniel Shalom
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    Director
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    IsraelIsraeli70363740001
    TORATI, Sharon
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    Director
    Units 13-15 Deane House Studios
    Greenwood Place
    NW5 1LB Highgate Road Kentish Town
    London
    IsraelIsraeli160404810001
    VLODINGER, Samuel
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    Director
    100 Clements Road
    SE16 4DG London
    Unit J209, The Biscuit Factory
    England
    IsraelIsraeli160404540001
    WALTERS, Raymond Archibald
    Nightingale Cnr Nightingale Road
    Bushey
    WD2 3NJ Watford
    Hertfordshire
    Director
    Nightingale Cnr Nightingale Road
    Bushey
    WD2 3NJ Watford
    Hertfordshire
    British52046110001

    ¿Tiene BAGIR (U.K.) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge over plant and equipment
    Creado el 17 ago 1994
    Entregado el 30 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of specific charge the plant and equipment and/or the proceeds of sale thereof being; respect thereof being;2 caroeusel pressing machines 180 degree high performance,for right/left forepart pressing serial number 112660 no.1-K84-46-09A-suk-54 masch 090303. no.2 Ipn K84-46-09A-suk-54 masch 090193 supplied by hornung gmbh indupress & co invoice no. 1378 dated 7 october 1993 plus various other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank Hapoalim B.M.
    Transacciones
    • 30 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over credit balances
    Creado el 10 mar 1992
    Entregado el 31 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge all monies from time to time held to the credit of the company by the bank on any current deposit or other account(s) now or hereafter with the bank or under any deposit receipt.
    Personas con derecho
    • Bank Leumi (U.K.) PLC
    Transacciones
    • 31 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 oct 1984
    Entregado el 25 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixture. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank Hapoalim Bm
    Transacciones
    • 25 oct 1984Registro de una carga
    • 10 dic 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0