NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 00559969 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
- Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Dirección de la sede social | 32 Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh Hampshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 ago 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 may 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 dic 2025 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 dic 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 dic 2024 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2025 | 5 páginas | AA | ||
Notification de Sharon Joanne Gamble en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 nov 2025 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Sharon Joanne Gamble el 11 nov 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cessation de Peter Francis Morrow en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 nov 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2024 | 5 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Judith Elizabeth Cowan como secretario el 12 feb 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Bruce Herring como director el 06 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Felicia Renee Gaule como director el 06 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Miss Hannah Gamble como director el 06 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mary Elizabeth Simons como director el 06 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2023 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Lawrence Michel Sylvestre como director el 15 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2022 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de John Timothy Trapp en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 jun 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cese del nombramiento de John Timothy Trapp como director el 10 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2021 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2020 | 5 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Notification de Peter Francis Morrow en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2020 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Bruce Herring en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||
Nombramiento de Mrs Taryn Baker como director el 25 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, Taryn | Director | Bolton Road BB2 4HL Blackburn 154 England | England | British | 277973500001 | |||||
| DUCKWORTH, Antony Richard | Director | 33 Gib Lane BB2 5BP Blackburn Lancashire | England | British | 31418420002 | |||||
| GAMBLE, Hannah | Director | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire United Kingdom | England | British | 329305530001 | |||||
| GAMBLE, Sharon Joanne | Director | 97 St Helens Road L34 6HP Prescot Merseyside | United Kingdom | British | 104991900002 | |||||
| GAULE, Felicia Renee | Director | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire United Kingdom | England | British | 329305690001 | |||||
| MORROW, Peter Francis | Director | Palma Close BN26 6QB Polegate 12 England | England | English | 18347990003 | |||||
| STAFFORD, Simon Edward | Director | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire | England | British | 224262670001 | |||||
| STAFFORD, Stephen Paul | Director | Straits Parade BS16 2LA Bristol 9 England | England | British | 220855970001 | |||||
| SYLVESTRE, Lawrence Michel | Director | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire | England | British | 166272810001 | |||||
| WRIGHT, Simon Tobias | Director | Barton Road Stretford M32 8DP Manchester 168 United Kingdom | United Kingdom | British | 149369050001 | |||||
| BRICHER, Geoffrey Walter | Secretario | 146 Welling Way DA16 2RS Welling Kent | British | Self Employed | 19170150001 | |||||
| BUTT, Pamela Shirley | Secretario | South Lodge 79 Glen Eyre Road SO16 3NN Southampton Hampshire | British | 21195830001 | ||||||
| COWAN, Judith Elizabeth | Secretario | 33 Buckland Avenue SL3 7PJ Slough Berkshire | British | 113122740001 | ||||||
| ARDALI, Ken | Director | 19 Whateley Close GU2 9LW Guildford Surrey | United Kingdom | British | Commercial Director | 118138720001 | ||||
| ASHTON, Murray | Director | 12 Randolph Avenue W9 1BP London | United Kingdom | British | Launderette Owner | 14551660001 | ||||
| CLARFELT, Jack | Director | 12 South Hill Park NW3 2SB London | British | Launderette Owner | 12647430003 | |||||
| DIXON, Tom Robert | Director | 3 Brandon Place GL50 2HF Cheltenham Gloucestershire | British | Sales Laundry | 79844570001 | |||||
| DOWLING, Patrick Junior | Director | White Squirrels 8 White Hart Wood TN13 1RR Sevenoaks Kent | British | Director | 17958150002 | |||||
| FLATTERS, Jack Raymond | Director | 96 Great Stone Road M16 0HD Manchester Lancashire | British | Launderette Owner | 21195870001 | |||||
| FROST, Alan | Director | 52 Osborne Street Bredbury SK6 2BT Stockport Cheshire | British | Launderette Proprietor | 21195880001 | |||||
| GLAZIER, Tony | Director | 9 Rush More Street CV31 3PU Leamington Warwickshire | British | Engineer | 80389570001 | |||||
| HAYES, David | Director | 32 Airedale Road Ealing W5 4SD London | British | Managing Director | 61839040002 | |||||
| HERRING, Bruce | Director | 2 Greenwood Close SM4 4HX Morden Surrey | England | British | Salesman | 111028250001 | ||||
| HIRST, Edward George | Director | 4 Haw Court Silkstone S75 4JF Barnsley South Yorkshire | British | Sales Director | 10136700001 | |||||
| HUGHES, Ivan | Director | 11 Greenwood Avenue NG3 7FX Nottingham Nottinghamshire | British | Service Manager Launderettes | 68033330001 | |||||
| KENNEDY, Ian | Director | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire United Kingdom | England | British | Launderette Owner | 67694250001 | ||||
| KHOSA, Harbinder Singh | Director | 18 Chudleigh Road TW2 7QR Twickenham Middlesex | British | Self Employed | 111078970001 | |||||
| KING, Lawrence | Director | 13 St Roberts Road HG5 8EQ Knaresborough North Yorkshire | British | Sales Manager | 11897700001 | |||||
| LAWSON, Keith Robert | Director | The Firs Millfields HP5 1SG Chesham Buckinghamshire | British | Co Director | 2899500001 | |||||
| LEITCH, Andrew Berton | Director | Daren Northfields TA11 6SL Somerton Somerset | British | Sales Manager | 21195850001 | |||||
| LOWERY, Peter Albert | Director | 43 Bulcote Drive Burton Joyce NG14 5AZ Nottingham Nottinghamshire | British | Launderette Owner | 23749270001 | |||||
| MARSHALL, Nicholas James George | Director | 5 Ullswater Putney SW15 6RY London | British | Journalist | 21195890001 | |||||
| MCHENRY, Thomas | Director | 16 Harland Way Southborough TN4 0TQ Tunbridge Wells Kent | British | Company Director | 6702400001 | |||||
| MCLEAN, Richard Michael | Director | 25 The Spinney Annitsford NE23 7NY Cramlington Northumberland | British | Manager | 67900650001 | |||||
| OFFORD, Anthony John | Director | Triton South Side SL9 8LU Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 5130930001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NATIONAL ASSOCIATION OF THE LAUNDERETTE INDUSTRY LIMITED (THE)?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mrs Sharon Joanne Gamble | 05 nov 2025 | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Peter Francis Morrow | 25 nov 2020 | Palma Close BN26 6QB Polegate 12 England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr John Timothy Trapp | 06 abr 2016 | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Bruce Herring | 06 abr 2016 | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Anthony Richard Duckworth | 06 abr 2016 | Hiltingbury Road Chandler's Ford SO53 5SS Eastleigh 32 Hampshire | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0