LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED

LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02470318
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Loxley House 2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JARDINE MOTORS GROUP UK LIMITED08 mar 200708 mar 2007
    JARDINE MOTORS GROUP PLC19 sept 199719 sept 1997
    JARDINE EUROPEAN MOTORS PLC02 abr 199002 abr 1990
    ASSETOPTION PUBLIC LIMITED COMPANY14 feb 199014 feb 1990

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 sept 2026
    Próxima declaración de confirmación vence29 sept 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta15 sept 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024

    61 páginasAA

    legacy

    4 páginasRP04SH01

    Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2025 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Tina Miller como director el 04 jul 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Holzshu como director el 04 jul 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 024703180003, creada el 01 abr 2025

    46 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Philip Daniel Wilbraham como director el 23 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como director el 02 sept 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Richard John Thomas como director el 02 sept 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023

    58 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed jardine motors group uk LIMITED\certificate issued on 28/08/24
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name28 ago 2024

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 28 ago 2024

    RES15

    Registro de la carga 024703180002, creada el 09 jul 2024

    46 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Porsche Centre Colchester Auto Way Ipswich Road Colchester Essex CO4 9HA United Kingdom a Loxley House 2 Oakwood Court, Little Oak Drive Annesley Nottingham NG15 0DR el 03 jun 2024

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mark Finch como secretario el 25 mar 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 25 mar 2024

    2 páginasAP03

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 feb 2024

    • Capital: GBP 97,500,000
    9 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    16 sept 2025Clarification A second filed SH01 was registered on 16/09/2025

    Memorándum y Estatutos

    18 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Share transfer 13/09/2023
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 024703180001, creada el 15 sept 2023

    36 páginasMR01

    Cambio de datos del secretario Mark Finch el 01 feb 2023

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr David Neil Williamson el 01 feb 2023

    2 páginasCH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022

    55 páginasAA

    Cese del nombramiento de David John Muir como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MALONEY, Richard James
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Secretario
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    321018710001
    IMPERT, Edward Charles
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    United StatesAmerican306760650001
    MALONEY, Richard James
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    EnglandBritish319094660001
    THOMAS, Richard John
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    EnglandBritish327027470001
    WILLIAMSON, David Neil
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    EnglandBritish199005320001
    FINCH, Mark
    Auto Way
    Ipswich Road
    CO4 9HA Colchester
    C/O Porsche Centre Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    Auto Way
    Ipswich Road
    CO4 9HA Colchester
    C/O Porsche Centre Colchester
    Essex
    United Kingdom
    175158070001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149294040001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Secretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secretario corporativo
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Director
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Director
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish206755450002
    BRADLEY, Eamon
    18 Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Oxfordshire
    Director
    18 Castle Street
    OX10 8DW Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish53412070002
    BROWN, Jeremy John Galbraith
    56 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Director
    56 Pont Street
    SW1X 0AE London
    United KingdomBritish5169660001
    FOSTER, Steven Gareth
    Heathgrove Barn
    Heath Road Sapiston
    IP31 1RY Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    Heathgrove Barn
    Heath Road Sapiston
    IP31 1RY Bury St Edmunds
    Suffolk
    British74811670001
    HAWKINS, Anthony Philip
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    Director
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    EnglandBritish107519840001
    HENDERSON, Martin Stuart
    4 Redan Street
    W14 0AD London
    Director
    4 Redan Street
    W14 0AD London
    United KingdomBritish2309640001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish123285980005
    HOLZSHU, Christopher
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    United StatesAmerican306760800001
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Director
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    British75730290003
    JONES, Alun Morton
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish12785600005
    JONES, Alun Morton
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    Director
    Fen House
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Suffolk
    United KingdomBritish12785600004
    KESWICK, Adam Philip Charles
    Auto Way
    Ipswich Road
    CO4 9HA Colchester
    C/O Porsche Centre Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Director
    Auto Way
    Ipswich Road
    CO4 9HA Colchester
    C/O Porsche Centre Colchester
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish211837820001
    KESWICK, Adam Phillip Charles
    28 Strawberry Hill
    8 Plunkett's Road, The Peak
    Hong Kong
    Director
    28 Strawberry Hill
    8 Plunkett's Road, The Peak
    Hong Kong
    British120585060001
    KESWICK, Simon Lindley
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    Director
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    EnglandBritish41736630003
    LEACH, Charles Guy Rodney, Lord
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    Director
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Matheson & Co Ltd
    United Kingdom
    United KingdomBritish4247280001
    LEE, Richard Grimsy
    Flat B 9th Floor
    227 Prince Edward Road
    Kowloon
    Hong Kong
    Director
    Flat B 9th Floor
    227 Prince Edward Road
    Kowloon
    Hong Kong
    Chinese38504260001
    MAUDE, Alan Stuart
    Holly Lodge Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Holly Lodge Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish507960007
    MICHELL, Rodney Drake Palmer
    20 Kensington Park Gardens
    W11 3HD London
    Director
    20 Kensington Park Gardens
    W11 3HD London
    British40206590001
    MILLER, Tina
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    Director
    2 Oakwood Court, Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    United StatesAmerican306760750001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish254017640001
    NEWBURY, David John
    Fieldfare
    Church Lane, Horton-Cum-Studley
    OX33 1AW Oxford
    Director
    Fieldfare
    Church Lane, Horton-Cum-Studley
    OX33 1AW Oxford
    EnglandBritish119205060001
    NIGHTINGALE, Anthony John Liddell
    11 Big Wave Bay
    Shek O
    Hong Kong
    Director
    11 Big Wave Bay
    Shek O
    Hong Kong
    British69304680001
    PANG, Yiu Kai
    Duplex 5, Dynasty Villa
    Dynasty Heights, 2-8 Yin Ping Road
    Beacon Hill
    Kowloon
    Hong Kong
    Director
    Duplex 5, Dynasty Villa
    Dynasty Heights, 2-8 Yin Ping Road
    Beacon Hill
    Kowloon
    Hong Kong
    Chinese87006740003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Lithia Uk Holding Limited
    207 Regent Street
    W1B 3HH London
    C/O Legalinx Limited 3rd Floor
    United Kingdom
    15 mar 2023
    207 Regent Street
    W1B 3HH London
    C/O Legalinx Limited 3rd Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House Registrar
    Número de registro14523998
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LITHIA MOTORS GROUP UK LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    01 may 201715 mar 2023La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0