KENDLE U.K. LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKENDLE U.K. LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02665779
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KENDLE U.K. LIMITED?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KENDLE U.K. LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Riverview The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KENDLE U.K. LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPECIALIST MONITORING SERVICES LIMITED24 mar 199724 mar 1997
    SPECIALIST SERVICES & EXPERTISE LIMITED25 nov 199125 nov 1991

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KENDLE U.K. LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KENDLE U.K. LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KENDLE U.K. LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    12 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 06 abr 2015

    • Capital: GBP 231,391
    4 páginasSH01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    39 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    resolution

    Resolución de capitalización o emisión de acciones de bonificación

    Capitalisation by way of the bonus issue to sole holder of £1 each ord shares of 300,000 06/04/2015
    RES14

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 abr 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 09/04/2015
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 25 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 dic 2014

    Estado de capital el 17 dic 2014

    • Capital: GBP 231,391
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 dic 2013

    Estado de capital el 12 dic 2013

    • Capital: GBP 231,391
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    16 páginasAA

    Nombramiento de Sally Michele Osmond como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kelvin Logan como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 25 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    17 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 25 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de KENDLE U.K. LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OSMOND, Sally Michele
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Director
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    UkBritishExecutive Vice President And General Manager177415470001
    ENDACOTT, Richard John
    47 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QP Twyford
    Berkshire
    Secretario
    47 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QP Twyford
    Berkshire
    British79267600001
    LEVINSON, Nigel Leslie
    9 Highcroft
    Cherry Burton
    HU17 7SG Beverley
    North Humberside
    Secretario
    9 Highcroft
    Cherry Burton
    HU17 7SG Beverley
    North Humberside
    British31970660001
    ROAKE, Susan
    87 Ashbrook Road
    Old Windsor
    SL4 2NE Windsor
    Berkshire
    Secretario
    87 Ashbrook Road
    Old Windsor
    SL4 2NE Windsor
    Berkshire
    BritishAccountant13212730001
    SINGH, Nyla Natalie
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Secretario
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    British53140790003
    BERGEN, Christopher
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Director
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    UsaUnited StatesDirector62057130002
    BRENKERT III, Karl
    981 Paxton Lake Drive
    Loveland
    Ohio 45140
    Usa
    Director
    981 Paxton Lake Drive
    Loveland
    Ohio 45140
    Usa
    AmericanDirector86872650002
    CHEESMAN, Keith A
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Director
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    UsaUnited StatesChief Financial Officer138222390001
    ENDACOTT, Richard John
    47 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QP Twyford
    Berkshire
    Director
    47 Old Bath Road
    Charvil
    RG10 9QP Twyford
    Berkshire
    BritishChartered Accountant79267600001
    FULLER, Edward John
    56 Broadwater Road
    Twyford
    RG10 0EU Reading
    Berkshire
    Director
    56 Broadwater Road
    Twyford
    RG10 0EU Reading
    Berkshire
    BritishDirector1129690002
    HALL, John Robert, Doctor
    The Red House Chatter Alley
    RG27 8SS Dogmersfield
    Hampshire
    Director
    The Red House Chatter Alley
    RG27 8SS Dogmersfield
    Hampshire
    BritishDirector43134380002
    KENDLE, Candace
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Director
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    UsaUnited StatesDirector62038310002
    LEVINSON, Nigel Leslie
    9 Highcroft
    Cherry Burton
    HU17 7SG Beverley
    North Humberside
    Director
    9 Highcroft
    Cherry Burton
    HU17 7SG Beverley
    North Humberside
    EnglandBritishClinical Research Consultant31970660001
    LOGAN, Kelvin Barry, Dr
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    Director
    The Meadows Business Park
    Station Approach Blackwater
    GU17 9AB Camberley
    Riverview
    Surrey
    United KingdomUnited KingdomDirector108775270002
    MARTIN, Paul Rowland
    1 Scarletts Cottages
    Scarletts Lane Kiln Green
    RG10 9XF Reading
    Berkshire
    Director
    1 Scarletts Cottages
    Scarletts Lane Kiln Green
    RG10 9XF Reading
    Berkshire
    BritishClinical Research Consultant31970670004
    MOONEY, Timothy
    5588 Squirrel Run Lane
    Cincinnati
    Ohio 45247
    Usa
    Director
    5588 Squirrel Run Lane
    Cincinnati
    Ohio 45247
    Usa
    AmericanDirector62038450001
    MOSS, Margaret Yvonne, Dr
    12 Little Warren Close
    GU4 8PW Guildford
    Surrey
    Director
    12 Little Warren Close
    GU4 8PW Guildford
    Surrey
    BritishClinical Researcher64004350001
    PEARCE, Denise Caroline
    Lavinia Forest Road
    SL5 8QF Ascot
    Berkshire
    Director
    Lavinia Forest Road
    SL5 8QF Ascot
    Berkshire
    BritishResearch Services38996790002
    PITCHFORD, Alan Gordon, Dr
    7 Condurrow Court
    GL54 1LX Stow-On-The-Wold
    Glos
    Director
    7 Condurrow Court
    GL54 1LX Stow-On-The-Wold
    Glos
    BritishMedical/Pharmaceutical Consultant21710650001
    RUANE, Thomas John
    46 The Cloisters
    Frimley
    GU16 5JR Camberley
    Surrey
    Director
    46 The Cloisters
    Frimley
    GU16 5JR Camberley
    Surrey
    IrishClinical Researcher64004380001
    SINGH, Nyla Natalie
    7 Causeway Cottages Cricket Green
    Hartley Wintney
    RG27 8PP Hampshire
    Director
    7 Causeway Cottages Cricket Green
    Hartley Wintney
    RG27 8PP Hampshire
    BritishAccountant53140790002

    ¿Tiene KENDLE U.K. LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 18 mar 2002
    Entregado el 21 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £36,495.50 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of £36,495.50 as security for the company's performance of the covenants on the part of the tenant contained in a lease of unit 36 wellington business park dukes ride crowthorne berkshire RG45 6LS.
    Personas con derecho
    • T a Fisher & Sons Limited
    Transacciones
    • 21 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 dic 2000
    Entregado el 04 ene 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 8TH september 1998 relating to unit 35 wellington business park dukes ride crowthorne berkshire
    Breve descripción
    £20,000.
    Personas con derecho
    • T a Fisher & Sons Limited
    Transacciones
    • 04 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Rent deposit deed
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 10 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,054 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date between the company (as tenant) and the chargee (as landlord) in relation to premises known as unit 25 (B2) wellington business park dukes ride crowthorne berkshire
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to the deposit account under the deed and the balance from time to time thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • T a Fisher (Holdings) Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 26 mar 1999
    Entregado el 10 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £35,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even dated between the company (as tenant) and the chargee (as landlord) relating to premises known as unit 38 (9B) wellington business park dukes ride crowthorne berkshire
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to the deposit account in relation to the deed and the balance from time to time thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • T.A. Fisher (Holdings) Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 31 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 05 sept 1995
    Entregado el 14 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Breve descripción
    £5,054.
    Personas con derecho
    • T.A. Fisher (Holdings) Limited
    Transacciones
    • 14 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 ago 1993
    Entregado el 16 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0