HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED

HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHALL & TAWSE NORTHERN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00369692
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Crown House
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MILLARD HOMES LIMITED30 sept. 194130 sept. 1941

    Quels sont les derniers comptes de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 02 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Westley Maffei le 01 oct. 2018

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Westley Maffei le 01 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 01 oct. 2018

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR à Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX le 01 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Carillion (Am) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018

    2 pagesPSC05

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Westley Maffei en tant que secrétaire le 01 juil. 2017

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Westley Maffei en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que secrétaire le 30 juin 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mai 2016

    État du capital au 03 mai 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 avr. 2015

    État du capital au 30 avr. 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 02 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY à Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR le 02 mars 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAFFEI, Westley
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    235171430001
    MAFFEI, Westley Anthony
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Administrateur
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssistant Company Secretary189962560002
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secrétaire
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Secrétaire
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Administrateur
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary24075160004
    MILLS, Lee James
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Administrateur
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant53951880001
    AM NOMINEES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    34427260007
    AM SECRETARIES LIMITED
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    Administrateur
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AZ London
    28265670010

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1367044
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 nov. 1995
    Livré le 08 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the chargors and/or any other obligor as defined therein to the chargee under each and any restructuring finance documents and the guarantee and debenture as defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 mai 1987
    Livré le 03 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the N.W. side of broad lane south, wednesfield, wolverhampton, west midlands tn: wm 150943.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 mai 1986
    Livré le 28 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due to the bank from k e millard & co. Limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Land at woodsetton k/a high arcall farm and land adjoining.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 mai 1986
    Livré le 28 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due to the bank from k e millard & co. Limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Land to the south side of marlborough road, woodsetton sedgley west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 mai 1986
    Livré le 15 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from k e millard & co limited on any account whatsoevers and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Land & buildings in the south west side of london road, daventry, northamptonshire. T.no:- nn 81181.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1984
    Livré le 08 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co. And from the company under the terms of the charge on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land on the east side of bath road st. Peter the great worcester in the county of hereford and worcester. Containing an area of 2.80 acres or thereabouts t/n:- hw 47443.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 09 juin 1984
    Livré le 09 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Land on the east side of bath road st peter the great worcester 5.2 acres or thereabouts t/n:- hw 40024.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 mars 1984
    Livré le 06 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever & from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    F/H land k/a fronting wychbury road, bartley green, birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 août 1983
    Livré le 31 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever & from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    F/H land at west meadow park brickbridge lane wombourne.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 1983
    Livré le 28 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from k e millard & company limited on any account whatsever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    High meadows, bagees road, kingswinford, W. midlands. T n: wm 248611.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 30 juin 1982
    Livré le 07 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1982
    Livré le 07 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co. Limited or any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    F/H land to the north side of the parkway, perton, staffs. T.n: sf 171959.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0