HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00369692 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?
| Adresse du siège social | Crown House Birch Street WV1 4JX Wolverhampton United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 02 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Westley Maffei le 01 oct. 2018 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Westley Maffei le 01 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 01 oct. 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR à Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX le 01 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion (Am) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Westley Maffei en tant que secrétaire le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Westley Maffei en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que secrétaire le 30 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 02 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 24 Birch Street Wolverhampton WV1 4HY à Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR le 02 mars 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAFFEI, Westley | Secrétaire | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | 235171430001 | |||||||
| MAFFEI, Westley Anthony | Administrateur | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | Assistant Company Secretary | 189962560002 | ||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secrétaire | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 | |||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | Chartered Secretary | 24075160004 | ||||
| MILLS, Lee James | Administrateur | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 53951880001 | ||||
| AM NOMINEES LIMITED | Administrateur | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 34427260007 | |||||||
| AM SECRETARIES LIMITED | Administrateur | Kinnaird House 1 Pall Mall East SW1Y 5AZ London | 28265670010 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Am) Limited | 06 avr. 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
HALL & TAWSE NORTHERN LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 23 nov. 1995 Livré le 08 déc. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each of the chargors and/or any other obligor as defined therein to the chargee under each and any restructuring finance documents and the guarantee and debenture as defined therein | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 15 mai 1987 Livré le 03 juin 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the N.W. side of broad lane south, wednesfield, wolverhampton, west midlands tn: wm 150943. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 mai 1986 Livré le 28 mai 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due to the bank from k e millard & co. Limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions Land at woodsetton k/a high arcall farm and land adjoining. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 mai 1986 Livré le 28 mai 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due to the bank from k e millard & co. Limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions Land to the south side of marlborough road, woodsetton sedgley west midlands. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 12 mai 1986 Livré le 15 mai 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from k e millard & co limited on any account whatsoevers and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions Land & buildings in the south west side of london road, daventry, northamptonshire. T.no:- nn 81181. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 20 déc. 1984 Livré le 08 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co. And from the company under the terms of the charge on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Land on the east side of bath road st. Peter the great worcester in the county of hereford and worcester. Containing an area of 2.80 acres or thereabouts t/n:- hw 47443. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 juin 1984 Livré le 09 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Brèves mentions Land on the east side of bath road st peter the great worcester 5.2 acres or thereabouts t/n:- hw 40024. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 mars 1984 Livré le 06 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever & from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions F/H land k/a fronting wychbury road, bartley green, birmingham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 31 août 1983 Livré le 31 août 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co limited on any account whatsoever & from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions F/H land at west meadow park brickbridge lane wombourne. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 23 févr. 1983 Livré le 28 févr. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from k e millard & company limited on any account whatsever and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions High meadows, bagees road, kingswinford, W. midlands. T n: wm 248611. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 30 juin 1982 Livré le 07 juil. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 30 juin 1982 Livré le 07 juil. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due to the bank from K.E. millard & co. Limited or any account whatsoever and from the company under the terms of the charge. | |
Brèves mentions F/H land to the north side of the parkway, perton, staffs. T.n: sf 171959. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0