RELATE MILTON KEYNES
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RELATE MILTON KEYNES |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 02796665 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RELATE MILTON KEYNES ?
| Adresse du siège social | The Relate Centre 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton Milton Keynes |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RELATE MILTON KEYNES ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RELATE MILTON KEYNES ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 19 mars 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour RELATE MILTON KEYNES ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Ms Beverley Dowsett en tant que secrétaire le 19 nov. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Ms Emma Jane Tanner en tant que secrétaire le 19 nov. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Hilary Williams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Thomas Edward Taylor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Volker Patent en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Hazel May Moore en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Bharatkumar Miangar en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Nicholas Lee Axtell en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Gintare Andrews en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Jessica Lucy Annison en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Donald Smith en tant que directeur le 07 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Kevin Donald Smith en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 avr. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 18 pages | MA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Gintare Andrews en tant qu'administrateur le 19 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Notification de Gintare Andrews en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Notification de Thomas Taylor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Notification de Kevin Smith en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Edward Taylor en tant qu'administrateur le 19 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Kevin Donald Smith en tant qu'administrateur le 19 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emily Sarah Pope en tant que directeur le 19 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Emily Sarah Pope en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 déc. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charlotte Ann Walsh en tant que directeur le 19 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RELATE MILTON KEYNES ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOWSETT, Beverley | Secrétaire | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | 342756390001 | |||||||
| TANNER, Emma Jane | Secrétaire | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | 342756320001 | |||||||
| ANDREWS, Gintare | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | Lithuanian | 331179790001 | |||||
| ANNISON, Jessica Lucy | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 328239400001 | |||||
| AXTELL, Nicholas Lee | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 321580770001 | |||||
| MIANGAR, Bharatkumar | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 267479190001 | |||||
| MOORE, Hazel May | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 321579810001 | |||||
| PATENT, Volker, Dr | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | German | 315061860001 | |||||
| TAYLOR, Thomas Edward | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 300452140001 | |||||
| WILLIAMS, Hilary | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 321580840001 | |||||
| FARROW, Brian | Secrétaire | 25 Edwards Croft Bradville MK13 7BU Milton Keynes Buckinghamshire | British | 122437150001 | ||||||
| MAIN, Roger | Secrétaire | 77 Stokenchurch Place Bradwell Common MK13 8AZ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 37719810001 | ||||||
| ROBERTS, Gwilym Huw | Secrétaire | 21 Aylesbury Street MK12 5HY Milton Keynes Buckinghamshire | Uk | 124841780001 | ||||||
| SKELTON, Anna Francesca | Secrétaire | 57 High Street Great Linford MK14 5AX Milton Keynes Buckinghamshire | British | 33436670001 | ||||||
| STREET, Jane Marian | Secrétaire | The Granary Grainge Chase, Little Horwood Road MK17 0QE Great Horwood Bucks | British | 112099890001 | ||||||
| ALLERTON, Elspeth Christine | Administrateur | 2 Pinkard Court Woughton On The Green MK6 3ET Milton Keynes Buckinghamshire | British | 53873110002 | ||||||
| ASLAM, Daanish | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 321578760001 | |||||
| BAILEY, Jonathan Richard | Administrateur | 13 Carnweather Court MK4 3DL Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 98428840001 | |||||
| BATES, John Neil | Administrateur | 10 Parkway Woburn Sands MK17 8UH Milton Keynes Buckinghamshire | British | 88721720001 | ||||||
| BLYTH, William Charles | Administrateur | 11 Nightingale Drive NN12 6RA Towcester Northamptonshire | British | 33436680001 | ||||||
| BOYES, Scilla | Administrateur | 5 Rushmere Close Bow Brickhill MK17 9JB Milton Keynes Buckinghamshire | British | 79223560001 | ||||||
| CALDER, Judith Ann, Dr | Administrateur | Brook Farm Willen Village MK15 9AD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 33436730001 | ||||||
| CATTELL, Donovan John | Administrateur | 41 The Leys Woburn Sands MK17 8QG Milton Keynes Buckinghamshire | British | 42413190002 | ||||||
| CHOPRA, Reginald | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | United Kingdom | British | 148751470002 | |||||
| CLAIRMONT, Eulina | Administrateur | 17 Church End Wavendon MK17 8NA Milton Keynes Buckinghamshire | British | 69954270001 | ||||||
| CLARK, Victoria Tamarind | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 209724800001 | |||||
| CONNOR, Robin | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 267278730001 | |||||
| CROCOMBE, Lindy | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | United Kingdom | British | 173684880001 | |||||
| DAVIDSON, Andrew | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | United Kingdom | British | 253122890002 | |||||
| DELLA-VENTURA, Domenico, Dr | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 100660680001 | |||||
| DELLA-VENTURA, Domenico, Dr | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | England | British | 100660680001 | |||||
| DING, Sharon Lynne, Dr | Administrateur | The Granary Broughton Road Milton Keynes Villag MK10 9AJ Milton Keynes Bucks | United Kingdom | British | 125307730001 | |||||
| FARROW, Brian | Administrateur | 25 Edwards Croft Bradville MK13 7BU Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 122437150001 | |||||
| FERGUSON, John William | Administrateur | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Great Britain | British | 155249920001 | |||||
| FORBES, Maureen Margaret | Administrateur | 12 Stanbrook Place Monkston MK10 9DW Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | 76087680001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RELATE MILTON KEYNES ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Thomas Edward Taylor | 19 déc. 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Gintare Andrews | 19 déc. 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: Lithuanian Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Kevin Donald Smith | 19 déc. 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Jessica Lucy Annison | 05 sept. 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Hazel May Moore | 07 mars 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Nicholas Lee Axtell | 07 mars 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Hilary Williams | 07 mars 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Daanish Aslam | 07 mars 2024 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Dr Volker Patent | 14 sept. 2023 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: German Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Christine Anne Griffin | 14 juil. 2022 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Miss Emily Sarah Pope | 01 déc. 2021 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Bharatkumar Miangar | 05 févr. 2020 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Robin Connor | 05 févr. 2020 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Andrew Davidson | 29 nov. 2018 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Susan Sawyer | 29 nov. 2018 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Charlotte Ann Walsh | 09 juin 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Miss Victoria Tamarind Clark | 09 juin 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Keith Lewington | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Mark Rayner | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Dr Domenico Della-Ventura | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Jane Marian Street | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Peter Houselander | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr John William Luff | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Nick Jackman | 06 avr. 2016 | 47 Aylesbury Street MK12 5HX Wolverton The Relate Centre Milton Keynes | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour RELATE MILTON KEYNES ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 11 nov. 2025 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0