CUBIC ACQUISITIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CUBIC ACQUISITIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05601280 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Cubic Business Centre 533 Stanningley Road LS13 4EN Leeds |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2014 au 31 mars 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 5 pages | MG01 | ||||||||||
legacy | MG01 | |||||||||||
legacy | 5 pages | MG01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Cleere Secretaries Limited en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 3 Limewood Way, Limewood Business Park, Leeds, LS14 1AB le 18 janv. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHMOOD HUSSAIN, Mansoor | Administrateur | 2 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | England | British | Property Developer | 108684740001 | ||||||||
| BLACKBURN, Amanda Jane | Secrétaire | 5 Wesley Road Farsley LS28 6EJ Leeds West Yorkshire | British | Accountant | 85146040001 | |||||||||
| KHAN, Amer | Secrétaire | 63 Springroyd Terrace BD8 9SN Bradford West Yorkshire | British | 103097840001 | ||||||||||
| MAHMOOD, Qulzam | Secrétaire | 2 Cedar Close Armley LS12 1SL Leeds West Yorkshire | British | Secretary | 100841760001 | |||||||||
| MAHMOOD, Qulzam | Secrétaire | 2 Cedar Close Armley LS12 1SL Leeds West Yorkshire | British | Secretary | 100841760001 | |||||||||
| MAHMOOD, Qulzam | Secrétaire | 2 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | British | 108684770001 | ||||||||||
| CLEERE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 3 Limewood Way Seacroft LS14 1AB Leeds |
| 100435440008 | ||||||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||||||
| MATTHEWS, David John | Administrateur | Treetops Harrogate Road, Bramhope LS16 9HY Leeds | England | British | Director | 15556400002 | ||||||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
CUBIC ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 03 avr. 2012 Livré le 24 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The f/h property k/a laurel terrace armley leeds west yorkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 03 avr. 2012 Livré le 07 avr. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 mars 2010 Livré le 07 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 3 laurel terrace armley leeds t/np WYE25690 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 mars 2010 Livré le 27 mars 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of assignment of rental income | Créé le 05 juin 2007 Livré le 12 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti £940,000.00 due or to become due from the company to | |
Brèves mentions The rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 juin 2007 Livré le 12 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All that land and buildings k/a 13 station lane featherstone pontfract. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 juin 2007 Livré le 12 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Land and buildings known as unit 1 bramley business centre stanningley road leeds t/n WYK470774. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 05 juin 2007 Livré le 12 juin 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 22 déc. 2006 Livré le 28 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H 2 church road armley leeds west yorkshire t/no YWE27207. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 04 sept. 2006 Livré le 07 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0