CUBIC ACQUISITIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCUBIC ACQUISITIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05601280
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cubic Business Centre
    533 Stanningley Road
    LS13 4EN Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 déc. 2015

    État du capital au 08 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2014 au 31 mars 2015

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2014

    État du capital au 10 déc. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2013

    État du capital au 29 oct. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    4 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    MG01

    legacy

    5 pagesMG01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Cleere Secretaries Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de , 3 Limewood Way, Limewood Business Park, Leeds, LS14 1AB le 18 janv. 2011

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CUBIC ACQUISITIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAHMOOD HUSSAIN, Mansoor
    2 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishProperty Developer108684740001
    BLACKBURN, Amanda Jane
    5 Wesley Road
    Farsley
    LS28 6EJ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Wesley Road
    Farsley
    LS28 6EJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant85146040001
    KHAN, Amer
    63 Springroyd Terrace
    BD8 9SN Bradford
    West Yorkshire
    Secrétaire
    63 Springroyd Terrace
    BD8 9SN Bradford
    West Yorkshire
    British103097840001
    MAHMOOD, Qulzam
    2 Cedar Close
    Armley
    LS12 1SL Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Cedar Close
    Armley
    LS12 1SL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSecretary100841760001
    MAHMOOD, Qulzam
    2 Cedar Close
    Armley
    LS12 1SL Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Cedar Close
    Armley
    LS12 1SL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSecretary100841760001
    MAHMOOD, Qulzam
    2 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British108684770001
    CLEERE SECRETARIES LIMITED
    3 Limewood Way
    Seacroft
    LS14 1AB Leeds
    Secrétaire
    3 Limewood Way
    Seacroft
    LS14 1AB Leeds
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5114787
    100435440008
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    MATTHEWS, David John
    Treetops
    Harrogate Road, Bramhope
    LS16 9HY Leeds
    Administrateur
    Treetops
    Harrogate Road, Bramhope
    LS16 9HY Leeds
    EnglandBritishDirector15556400002
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    CUBIC ACQUISITIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2012
    Livré le 24 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property k/a laurel terrace armley leeds west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Bridging Finance Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2012
    Livré le 07 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bridging Finance Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 2010
    Livré le 07 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 laurel terrace armley leeds t/np WYE25690 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 mars 2010
    Livré le 27 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 05 juin 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £940,000.00 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    The rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All that land and buildings k/a 13 station lane featherstone pontfract.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 juin 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land and buildings known as unit 1 bramley business centre stanningley road leeds t/n WYK470774.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juin 2007
    Livré le 12 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 28 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H 2 church road armley leeds west yorkshire t/no YWE27207. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 sept. 2006
    Livré le 07 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0