G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED

G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI010894
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières

    Où se situe G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au13 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu des recettes et des dépenses au 27 août 2019

    6 pages4.69(NI)

    Procès-verbal de la réunion finale dans une liquidation volontaire des associés

    3 pages4.72(NI)

    Comptes d'exonération totale établis au 13 déc. 2017

    8 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mai 2018 au 13 déc. 2017

    3 pagesAA01

    Compte rendu des recettes et des dépenses au 13 déc. 2018

    6 pages4.69(NI)

    Avis de cessation d'activité en tant que liquidateur volontaire

    9 pages4.41(NI)

    Nomination d'un liquidateur

    1 pagesVL1

    Comptes consolidés établis au 31 mai 2017

    33 pagesAA

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.71(NI)

    Nomination d'un liquidateur

    1 pagesVL1

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    insolvency

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESM(NI)

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mai 2016

    30 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 févr. 2016

    État du capital au 10 févr. 2016

    • Capital: GBP 33,366
    SH01

    Comptes consolidés établis au 31 mai 2015

    24 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 nov. 2014

    État du capital au 05 nov. 2014

    • Capital: GBP 33,366
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2014

    État du capital au 02 juin 2014

    • Capital: GBP 33,366
    SH01

    Qui sont les dirigeants de G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NAPIER, Claire Anne
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Secrétaire
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Irish144611820001
    HUNTER, Tracey
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Administrateur
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Northern IrelandIrish144611790001
    NAPIER, Claire Anne
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Administrateur
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Northern IrelandIrish144611820001
    MCMANUS, Dermot Gerald
    22 Cooper Crescent
    Chanterhill
    BT74 7EJ Enniskillen
    Secrétaire
    22 Cooper Crescent
    Chanterhill
    BT74 7EJ Enniskillen
    144611780001
    TUNNEY, Gail
    10 Chanterhill Road
    Enniskillen
    BT74 Co Fermanagh
    Administrateur
    10 Chanterhill Road
    Enniskillen
    BT74 Co Fermanagh
    Irish144611800001
    VAUGHAN, Jean
    4 Abbey View
    Maguiresbridge
    BT94 4ST Enniskillen
    Fermanagh
    Administrateur
    4 Abbey View
    Maguiresbridge
    BT94 4ST Enniskillen
    Fermanagh
    Gb144611810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Tracey Hunter
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    01 nov. 2016
    Carran Business Park
    Enniskillen
    BT74 4RZ Co Fermanagh
    Non
    Nationalité: Irish
    Pays de résidence: Northern Ireland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.

    G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage or charge
    Créé le 18 oct. 1995
    Livré le 26 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage title number:WM399942 (freehold) and WM94206 (leasehold) the freehold porperty known as ledra works, northgate aldridge west midlands and the leasehold interest therein.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1995Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 13 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 03 janv. 1992
    Livré le 09 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage/charge the freehold property being "all that and those portion of the premises known as 74 irvinestown rd, enniskillen situate in the townland of drumclay and borough of enniskillen and more part- icularly described and delineated on the map attached to the hereinbefore recited statutory declaration dated the 28/5/91 and comprised in the following documents 28TH may 1991, statutory declaration, gerard burns 17TH october 1991, conveyance, fermanagh district council to gt exhausts (NI) LTD.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank NI PLC
    Transactions
    • 09 janv. 1992Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 13 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 27 févr. 1990
    Livré le 01 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage debenture 1.by way of mortgage the premises held under an indenture of conveyance dated 7/4/78 made between graceys (fermanagh) limited of the one part and gt exhausts (NI) limited of the other part being premises containing 2,287 sq metres or thereabouts and 204 sq metres which are known as 74 irvinestown rd enniskillen county fermanagh. 2.By way of charge all the lands and premises containing 1 acre and 105 sq yards at 74 irvinestown rd enniskillen in the co of fermanagh together with the buildings and other erections thereon the title whereto is registered in folio 7421 county fermanagh. 3.By way of specific equitable charge all future,freehold and leasehold pro- perty belonging to the company during the continuance of this security. 4.By way of specific charge all stocks, shares and other securities now or at any time during the continuance of this security belonging to the company in any of its subsiduary companies. 5.By way of specific charge all book and other debts now and from time to time due or owing to the company. 6.By way of floating charge its under- taking and all its assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including building and trade fixtures, fixed plant and machinery. 7.By way of assignment its goodwill sub- ject to redemption of the liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank NI PLC
    Transactions
    • 01 mars 1990Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 13 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 26 oct. 1983
    Livré le 27 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    172550
    Brèves mentions
    Mortgage and floating charge 1. the premises at irvinestown road, enniskillen, county fermanagh as com- prised in land registry folio 7421 county fermanagh. (B) conveyance dated the 7/4/78 made between graceys (fermanagh) limited and G.T.exhausts (N.I.) limited of the other part. 2. the undertaking and all the property of the company whatsoever and whereso ever both present and future including its uncalled capital for the time being if any. The company shall not be at liberty to create without previous written consent of the local enterprise development unit any mortgage charge or lien on any of its assets ranking priority hereto or pari passu herewith.
    Personnes ayant droit
    • Local Enterprise
    Transactions
    • 27 oct. 1983
    Mortgage or charge
    Créé le 20 sept. 1982
    Livré le 24 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies specific charge a specific charge oer:- 1. overhead crane aabacas 5 ton hdl 5271 2. compressor 1HY 327804/3 43 pbm 3. lorry commer dji 6265 4. containers 01.40 dennison 40FT 01.41 dennison 40FT 01.42 york 40FT 01.43 frauhauf 40FT 01.44 frauhauf 40FT 01.45 tasker 40FT 01.46 dennison 40FT 01.47 dennison 40FT.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 24 sept. 1982Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 20 sept. 1982
    Livré le 24 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Charge over book debts a fixed charge over:- all the book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company but so that the company shall pay into the company's account with the bank all moneys which it may recieve in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or otherwise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to the bank.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 24 sept. 1982Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 01 mars 1982
    Livré le 02 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Fixed & floating charge 1. premises at irvinestown road, enniskillen, co. Fermanagh as comprised in (a) land registry folio 7421 county fermanagh and (b) conveyance dated 7/4/78 and made between gracey's (fermanagh) limited of the one part and G.T.exhausts (N.I.) limited of the other part. 2. the undertaking and all the property of the company whatsoever and whereso- ever both present and future including its uncalled capital for the time being if any. The said deed of floating charge provides that the company shall not be at liberty to create without the previous written consent of local enterprise development unit any mortgage charge or lien on any of its assets ranking in priority thereto or pari passu therewith.
    Personnes ayant droit
    • Local Enterprise
    Transactions
    • 02 mars 1982
    Mortgage or charge
    Créé le 27 oct. 1978
    Livré le 30 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    150000
    Brèves mentions
    Mortgage part of the lands of drumclay at irvinestown rd, enniskillen, county fermanagh as comprised in conveyance dated the 7/4/78 and made between graceys (fermanagh) limited of the one part and the company of the other part.
    Personnes ayant droit
    • Local Enterprise
    Transactions
    • 30 oct. 1978Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 11 août 1978
    Livré le 15 août 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    150000
    Brèves mentions
    Deed of fixed and floating charge 1. premises at irvinstown road, enniskillen co. Fermanagh as comprised in folio 7421 in the land registry. 2. the undertaking and all the property and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being if any. The deed provides that the company shall not be at liberty to create without the previous written consent of the unit any mortgage or charge or lien on any of its assets ranking in priority there to or pari passu therewith.
    Personnes ayant droit
    • Local Enterprise
    Transactions
    • 15 août 1978Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 31 juil. 1978
    Livré le 07 août 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Legal mortgage. The company's premises situate at drum- clay, irvinestown road, enniskillen co. Fermanagh (and comprised in indenture of conveyance dated 7/4/78 made between grancey (fermanagh) limited of the one part and the company of the other part).
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 07 août 1978Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 29 avr. 1976
    Livré le 30 avr. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    80000
    Brèves mentions
    Deed of floating and fixed charge 1. premises at irvinestown road, enniskillen co. Fermanagh as comprised in folio 7421 co. Fermanagh of the land registry of northern ireland. 2. the undertaking and all the property of the company whatsoever and whereso- ever both present and future including its uncalled capital for the time being if any. The said deed of floating and fixed charge provides that the company shall not be at liberty to create without the previous written consent of local enterprise development unit any mortgage charge or lien on any of its assets ranking in priority thereto or pari passu therewith.
    Personnes ayant droit
    • Local Enterprise
    Transactions
    • 30 avr. 1976Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 05 avr. 1976
    Livré le 06 avr. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies deed of charge a fixed charge over:- the company's lands and premises comprised in folio no. 7421 county fermanagh land registry of northern ireland.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 06 avr. 1976Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 11 mars 1976
    Livré le 19 mars 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Debenture floating charge over the undertaking of the company and all its property both present and future including its uncalled capital for the time being.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 19 mars 1976Enregistrement d'une charge (402 NI)

    G.T. EXHAUSTS (N.I.) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 déc. 2017Commencement of winding up
    03 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Armstrong
    Number One Lanyon Quay
    BT1 3LG Belfast
    practitioner
    Number One Lanyon Quay
    BT1 3LG Belfast
    Lindsey J Cooper
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    practitioner
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Gregg Sterritt
    Rsm Number One
    Lanyon Quay
    BT1 3LG Belfast
    practitioner
    Rsm Number One
    Lanyon Quay
    BT1 3LG Belfast

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0