ELPHINSTONE ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéELPHINSTONE ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC314988
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    • (7012) /

    Où se situe ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O INTERPATH
    5th Floor, 130 St. Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MM&S (5193) LIMITED19 janv. 200719 janv. 2007

    Quels sont les derniers comptes de ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Passage de l'administration à la dissolution

    26 pagesAM23(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    3 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    3 pagesAM19(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Interpath Limited 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS à 5th Floor, 130 st. Vincent Street Glasgow G2 5HF le 08 févr. 2022

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG à C/O Interpath Limited 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mai 2021

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    3 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    3 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    4 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pages2.20B(Scot)

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    4 pages2.31B(Scot)

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    4 pages2.30B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pages2.20B(Scot)

    Qui sont les dirigeants de ELPHINSTONE ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Secrétaire
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    BritishAccountant45302060001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishBanker73849040001
    BURNETT, Neil Scott
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    United Kingdom
    Administrateur
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritishInvestment Manager93937250003
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishBanker113081830001
    MACDONALD, Gary
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    BritishBanker127023890001
    MARTIN, John Keith
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritishAccountant45302060001
    ROSS, Kenneth
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    Administrateur
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritishProperty Developer41012110004
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    ELPHINSTONE ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 17 déc. 2009
    Livré le 06 janv. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Three areas of ground lying generally to the southwest of mauricewood road, penicuik.
    Personnes ayant droit
    • Robin Brock
    Transactions
    • 06 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6, 9.7 & 13 hectares) at whitehill farm, newtown st boswells. 2 areas of land (1.1 & 2.5 hectares) at the holmes farm, newtown st boswell and 2 areas of land (1.8 hectares & 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Alexander Paterson Dale
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6, 9.7 & 13 hectares) at whitehill farm, newtown st boswells, 2 areas of land (1.1 & 2.5 hectares) at the holmes farm, newtown st boswells & 2 areas of land (1.8 & 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Alexander Paterson Dale and Others
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    1.8 hectares at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fraser Dale and Others
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6, 9.7 & 13 hectares) at whitehill farm, newtown st boswells, 2 areas of land (1.1 & 2.5 hectares) at holmes farm, newtown st boswells and 2 areas of land (2.8 and 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fraser Dale and Others
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2008
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    2 areas of land (13 & 2.5 hectares) at whitehill and holmes farms, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • John Donald Hunter Gordon
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6, 9.7 & 13 hectares) at whitehill farm, newtown st boswells. 2 areas of land (1.1 & 2.5 hectares) at the holmes farm, newtown st boswells and 2 areas of land (1.8 & 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • John Donald Hunter Gordon
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6, 9.7 & 13 hectares) at whitehill farm, newtown st boswells. 2 areas of land (1.1 & 2.5 hectares) at the holmes farm, newtown st boswells and 2 areas of land 1.8 & 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • John Donald Hunter Gordon
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    2 areas of land (13 & 2.5 hectares) at whitehill and the holmes farm, newton, st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Alexander Paterson Dale
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 30 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    The obligations pursuant to the missives
    Brèves mentions
    3 areas of land (37.6 hectares, 9.7 hectares & 13 hectares) at whitehill farm, newtowm st boswells. 2 areas (1.1 hectares & 2.5 hectares) at the holmes farm, newtown st boswells and 2 areas (1.8 hectares & 7.8 hectares) at the holmes, newtown st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Alexander Paterson Dale
    Transactions
    • 30 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2008
    Livré le 29 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at newton st boswells.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 24 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Broxy kennels, regorton, perth PTH32509.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 22 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at kildean, stirling in the county of stirling extending to 8.529 acres or thereby STG58976.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 23 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The areas of ground at polmaise, stirling, in the county of stirling STG58977.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 22 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at kildean in the county of stirling extending to 18.7 acres or thereby STG58987.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 avr. 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due and to become due in terms of the agreement
    Brèves mentions
    Three areas of ground lying generally to the soutwest of mauricewood road, penicuik in the county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • Robin Brock
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 19 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two areas of ground to south and south west of belwood road & mauricewood road, penicuik.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 19 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground to southwest of mauricewood road, penicuik, midlothian MID102555.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation in security
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 11 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company's whole right, title, interest and benefit in and to the contract and all rights associated with the contract.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 29 mars 2007
    Livré le 11 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juin 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 mai 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 29 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All of the companys liabilities pursuant to the agreement
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mr Robert (Otherwise Robin) Brock
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)

    ELPHINSTONE ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2010Administration started
    22 mars 2024Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Alistair Mcalinden
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen
    Grampian
    practitioner
    37 Albyn Place
    AB10 1JB Aberdeen
    Grampian
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    practitioner
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0