Alan Arthur NIXON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Alan |
Deuxième prénom | Arthur |
Nom de famille | NIXON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 8 |
Démissionné | 58 |
Total | 66 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWK HOMES (BROMBOROUGH) LIMITED | 20 juin 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY13 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British | |
HAWK HOMES BICTON LTD | 12 avr. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Brown Heath SY12 0LB Ellesmere The Old House Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
HAWK HOMES THREAPWOOD LTD | 28 mars 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Brown Heath SY12 0LB Ellesmere The Old House Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
HD PARKTHORNE JV LTD | 15 févr. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Brown Heath SY12 0LB Ellesmere The Old House Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
JOINT VENTURE 2-HD LIMITED | 09 déc. 2004 | Dissoute | Accountant | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British | |
JOINT VENTURE 2-HD LIMITED | 09 déc. 2004 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | ||
QPNG LIMITED | 09 déc. 2004 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | ||
QPNG LIMITED | 09 déc. 2004 | Dissoute | Accountant | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British | |
CHARLESTON WAY CONSULTANCY LIMITED | 10 mai 2007 | 18 déc. 2024 | Active | Director | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
DRIVERS TODAY LTD | 14 janv. 2008 | 09 mai 2022 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWK GROUP LIMITED | 07 mars 2002 | 09 mai 2022 | Dissoute | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | ||
HAWK HOMES LIMITED | 09 déc. 2004 | 10 déc. 2021 | Active | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWKINS PLANT | 25 juil. 2007 | 06 déc. 2021 | Dissoute | Director | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWK ASSET HOLDINGS LIMITED | 08 avr. 2002 | 30 sept. 2021 | Active | Director | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWK VEHICLE HIRE LIMITED | 08 avr. 2002 | 01 juil. 2021 | Active | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWK (WEM) 3 LTD | 17 déc. 2004 | 01 avr. 2021 | Active | Accountant | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWKINS GARAGES (WEM) LIMITED | 08 avr. 2002 | 01 avr. 2021 | Active | Director | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
HAWKRENT LIMITED | 01 août 2001 | 01 avr. 2021 | Dissoute | Director | Secrétaire | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | British | |
EZE AIR LIMITED | 09 déc. 2004 | 01 avr. 2021 | Liquidation | Accountant | Secrétaire | 2 Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange Shropshire United Kingdom | British | |
HAWKINVESTING LIMITED | 17 août 2015 | 08 mars 2021 | Active | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY13 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British |
HAWK (WEM) 3 LTD | 17 déc. 2004 | 08 mars 2021 | Active | Accountant | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
HAWKINS GARAGES (WEM) LIMITED | 30 juil. 2001 | 08 mars 2021 | Active | Director | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
FRANKTON FIELDS PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LTD | 07 mai 2019 | 08 mars 2021 | Dissoute | None | Administrateur | Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange, 2 Shropshire | United Kingdom | British |
HAWK HOMES WEM LIMITED | 20 janv. 2017 | 08 mars 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY13 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British |
HAWK HOMES (OLD MARTON) LTD | 01 juil. 2013 | 08 mars 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | Brown Heath SY12 0LB Ellesmere The Old House Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British |
HAWKRENT LIMITED | 01 août 2001 | 08 mars 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
EZE AIR LIMITED | 09 déc. 2004 | 08 mars 2021 | Liquidation | Accountant | Administrateur | 2 Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British |
FOX GLOVE PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 20 déc. 2019 | 15 févr. 2021 | Active | Director | Administrateur | 2 Aston Street Wem SY4 5AY Shrewsbury The Grange United Kingdom | United Kingdom | British |
OLD MARTON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 17 août 2018 | 15 févr. 2021 | Active | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY12 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British |
CHARLESTON WAY CONSULTANCY LIMITED | 10 mai 2007 | 15 févr. 2021 | Active | Director | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
HAWK HOMES LIMITED | 09 déc. 2004 | 15 févr. 2021 | Active | Accountant | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
HAWK VEHICLE HIRE LIMITED | 30 juil. 2001 | 15 févr. 2021 | Active | Accountant | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
HAWK ASSET HOLDINGS LIMITED | 30 juil. 2001 | 15 févr. 2021 | Active | Director | Administrateur | The Old House Brown Heath SY12 0LB Ellesmere Shropshire | United Kingdom | British |
HAWK HOMES LYNEAL LIMITED | 20 nov. 2017 | 15 févr. 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY13 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British |
HAWKRENT SERVICES LIMITED | 22 nov. 2013 | 15 févr. 2021 | Dissoute | Director | Administrateur | Cruckmoor Lane Prees Green SY13 2BS Whitchurch Charleston House Shropshire England | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0