Warren Newton JACKSON
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Warren |
Deuxième prénom | Newton |
Nom de famille | JACKSON |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 23 |
Total | 30 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAKE AUSTIN RESORTS LIMITED | 28 avr. 2009 | Dissoute | Director | Administrateur | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | England | British | |
JAMES CHRISTIAN HOMES LIMITED | 28 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |||
HUNTLAND HOMES LIMITED | 10 déc. 2006 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
STAFFORDSHIRE LOCOMOTIVE COMPANY LIMITED | 06 mai 2002 | Dissoute | Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
PHONIQ LIMITED | 01 mai 2002 | Dissoute | Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
BRIGHT PLANET LIMITED | 24 avr. 2002 | Dissoute | Sales Director | Administrateur | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | England | British | |
BRIGHT PLANET LIMITED | 24 avr. 2002 | Dissoute | Sales Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
THREE PIN SOCKET LIMITED | 26 févr. 2008 | 08 mars 2021 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
VULCAN FOUNDRY LIMITED | 22 juil. 2005 | 08 mars 2021 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
ROBERT STEPHENSON & HAWTHORNS LIMITED | 21 juil. 2005 | 08 mars 2021 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
R & W HAWTHORN LESLIE & CO. LIMITED | 21 juil. 2005 | 08 mars 2021 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
ROBERT STEPHENSON & CO. LIMITED | 21 juil. 2005 | 08 mars 2021 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
M.J. ONE LIMITED | 09 déc. 2007 | 17 août 2016 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Bennett Corner House 33 Coleshill Street B72 1SD Sutton Coldfield West Midlands | British | |
YOSHI GOODS LIMITED | 15 oct. 2009 | 11 mai 2013 | Active | Director | Administrateur | Bennett Corner House 33 Coleshill Street B72 1SD Sutton Coldfield - West Midlands England | England | British |
BLUE SQUARE COMMERCIAL (WOODSIDE) LIMITED | 08 juin 2009 | 06 mars 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | 33 Coleshill Street B72 1SD Sutton Coldfield Bennett Corner House West Midlands | England | British |
LEGAL DRAFTING SERVICES LIMITED | 25 juil. 2008 | 16 déc. 2009 | Dissoute | Director | Administrateur | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | England | British |
TOOJISTAR LIMITED | 08 juil. 2008 | 05 janv. 2009 | Dissoute | Director | Administrateur | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | England | British |
CASE TOSCANA LIMITED | 31 mai 2005 | 18 sept. 2008 | Active | Director | Administrateur | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | England | British |
CEMA INTERNATIONAL LIMITED | 06 juil. 2004 | 28 juil. 2008 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
PH LOGISTICS UK LIMITED | 07 mars 2006 | 09 juil. 2008 | Active | Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |
MAGURA ESTATES LIMITED | 07 janv. 2008 | 09 juil. 2008 | Dissoute | Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |
PREMIER PLANNED MAINTENANCE LIMITED | 11 oct. 2006 | 09 juil. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
M M (ELECTRICAL ENGINEERS & CONTRACTORS) LIMITED | 11 oct. 2005 | 09 juil. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
PNL PROPERTIES LIMITED | 31 juil. 2005 | 09 juil. 2008 | Dissoute | Director | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |
CC ASSOCIATES LIMITED | 04 janv. 2007 | 09 juil. 2008 | Liquidation | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
NM CONSULTING (UK) LIMITED | 20 avr. 2007 | 06 avr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |
FLAVOURS (MIDLANDS) LIMITED | 14 nov. 2006 | 31 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
INCLUSIVE FUTURES LIMITED | 02 oct. 2007 | 01 févr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | |
WHITE WALL GALLERIES LIMITED | 15 mai 2006 | 18 mai 2007 | Active | Secrétaire | Wheelwright Cottage 31 Wheel Lane WS13 7DH Lichfield | British | ||
FENVISE LIMITED | 22 févr. 2004 | 31 déc. 2005 | Active | Director | Secrétaire | The Great Barn Manor Yard WS15 3RS Hamstall Ridware Staffordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0