Paul Francis FERGUSON
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Paul |
| Deuxième prénom | Francis |
| Nom de famille | FERGUSON |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 6 |
| Inactif | 6 |
| Démissionné | 4 |
| Total | 16 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STROUD DEVELOPMENTS LTD | 15 janv. 2019 | Active | Administrateur | 1 North Avenue Clydebank Business Park G81 2DR Clydebank C/0 Zoom 3rd Floor Erskine House Scotland | Scotland | British | ||
| ZKL LTD | 26 nov. 2018 | Active | Administrateur | Merlin House C/O Defacto Fd Mossland Road G52 4XZ Glasgow Merlin House United Kingdom | Scotland | British | ||
| UK TEAM SERVICES LTD | 17 nov. 2017 | Active | Administrateur | Montgomery Place East Kilbride G74 4BF Glasgow Office 4 Admiral House Scotland | Scotland | British | ||
| S2 TEAM SERVICES LTD | 14 nov. 2017 | Active | Administrateur | Montgomery Place East Kilbride G74 4BF Glasgow Admiral House Scotland | Scotland | British | ||
| STROUD ESTATES LTD | 25 nov. 2016 | Active | Administrateur | 1 North Avenue Clydebank Business Park G81 2DR Clydebank C/0 Zoom 3rd Floor Erskine House Scotland | Scotland | British | ||
| P & J PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 21 févr. 2012 | Active | Administrateur | 5 Bank Street BL9 0DN Bury The Exchange Lancashire England | Scotland | British | ||
| ADMIRAL (CAMBUSLANG) LIMITED | 20 mai 2011 | Dissoute | Administrateur | Avondale Gardens G74 1NE East Kilbride 2 Glasgow United Kingdom | Scotland | British | ||
| ADMIRAL HOMES (LESMAHAGOW) LIMITED | 12 oct. 2010 | Dissoute | Administrateur | Avondale Gardens G74 1NE East Kilbride 2 United Kingdom | Scotland | British | ||
| WARLAW RENEWABLES LIMITED | 14 sept. 2010 | Dissoute | Administrateur | Avondale Gardens G74 1NE East Kilbride 2 United Kingdom | Scotland | British | ||
| VACLENSA COMMERCIAL CLEANING MACHINES LIMITED | 09 juil. 1997 | Dissoute | Administrateur | Bellam Court Wardley, Swinton M27 9GD Manchester 25 England | England | British | ||
| DECARBONIZER (INTERNATIONAL) LTD. | 07 janv. 1997 | Dissoute | Secrétaire | 12 Baird Avenue Strutherhill Industrial Estate ML9 2PJ Larkhall Service House Lanarkshire Scotland | British | |||
| DECARBONIZER (INTERNATIONAL) LTD. | 17 janv. 1995 | Dissoute | Administrateur | 12 Baird Avenue Strutherhill Industrial Estate ML9 2PJ Larkhall Service House Lanarkshire Scotland | England | British | ||
| DONAL TONER ASSOCIATES LTD | 21 janv. 2008 | 02 avr. 2019 | Active | Administrateur | 2 Avondale Gardens G74 1NE East Kilbride | Scotland | British | |
| ADMIRAL HOMES (SCOTLAND) LIMITED | 01 déc. 2005 | 02 avr. 2019 | Dissoute | Administrateur | 2 Avondale Gardens G74 1NE East Kilbride | Scotland | British | |
| TEAM SERVICES FIRE SYSTEMS LTD | 29 mars 2018 | 21 déc. 2018 | Active | Administrateur | 31 Main Street Village G74 4JU East Kilbride Oakfield House Business Centre South Lanarkshire Scotland | Scotland | British | |
| VACLENSA LIMITED | 17 janv. 2002 | 06 avr. 2017 | Active | Administrateur | 21 Shield Drive Wardley Industrial Estate M28 2QB Worsley Service House Manchester | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0