Eileen Theresa ROGAN
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Eileen |
Deuxième prénom | Theresa |
Nom de famille | ROGAN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 27 |
Total | 27 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARD HADAWAY INCORPORATIONS LIMITED | 07 juil. 1999 | 31 juil. 2016 | Dissoute | Administrator | Secrétaire | Sandgate House 102 Quayside Newcastle Upon Tyne NE1 3DX Tyne & Wear | British | |
WARD HADAWAY INCORPORATIONS LIMITED | 07 juil. 1999 | 18 sept. 2008 | Dissoute | Administrator | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
SWIFT BRAKE & CLUTCH LIMITED | 14 juil. 1999 | 20 août 1999 | Active | Legal Secretary | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
SWIFT BRAKE & CLUTCH LIMITED | 14 juil. 1999 | 20 août 1999 | Active | Legal Secretary | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
DATAFORM (MIDLANDS) LIMITED | 26 août 1997 | 15 déc. 1997 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
DATAFORM (MIDLANDS) LIMITED | 26 août 1997 | 15 déc. 1997 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
ARGONAUTICS LIMITED | 29 juin 1995 | 18 oct. 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | 34 Bondene Avenue West Felling NE10 9NL Gateshead Tyne & Wear | British | |
ARGONAUTICS LIMITED | 29 juin 1995 | 18 oct. 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | 34 Bondene Avenue West Felling NE10 9NL Gateshead Tyne & Wear | British | |
TEAMS ENTERPRISE PARTNERSHIP LIMITED | 28 juin 1996 | 23 juil. 1996 | Dissoute | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | ||
AUDUS NOBLE LIMITED | 27 déc. 1995 | 10 mai 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
AUDUS NOBLE LIMITED | 27 déc. 1995 | 10 mai 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
RCL INDUSTRIES LIMITED | 27 déc. 1995 | 15 févr. 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
RCL INDUSTRIES LIMITED | 27 déc. 1995 | 15 févr. 1996 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
CENTRELAND PARTNERSHIPS LIMITED | 28 nov. 1995 | 18 janv. 1996 | Liquidation | Legal Secretary | Secrétaire | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
CENTRELAND PARTNERSHIPS LIMITED | 28 nov. 1995 | 18 janv. 1996 | Liquidation | Legal Secretary | Administrateur | 54 York Street Pelaw NE10 0QL Gateshead Tyne & Wear | British | |
YORKSHIRE LAVENDER LIMITED | 15 août 1995 | 18 oct. 1995 | Liquidation | Company Secretary | Secrétaire | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
YORKSHIRE LAVENDER LIMITED | 15 août 1995 | 18 oct. 1995 | Liquidation | Company Secretary | Administrateur | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
CHRISTISON TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 29 juin 1995 | 11 oct. 1995 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | 34 Bondene Avenue West Felling NE10 9NL Gateshead Tyne & Wear | British | |
CHRISTISON TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 29 juin 1995 | 11 oct. 1995 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | 34 Bondene Avenue West Felling NE10 9NL Gateshead Tyne & Wear | British | |
WALLACE LANDSCAPING LIMITED | 28 mars 1995 | 08 août 1995 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
WALLACE LANDSCAPING LIMITED | 28 mars 1995 | 08 août 1995 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
GAS-TEC LIMITED | 28 mars 1995 | 07 juin 1995 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
GAS-TEC LIMITED | 28 mars 1995 | 07 juin 1995 | Dissoute | Company Secretary | Administrateur | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
BDW TRADING LIMITED | 03 févr. 1995 | 25 mars 1995 | Active | Legal Secretary | Administrateur | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
BDW TRADING LIMITED | 03 févr. 1995 | 25 mars 1995 | Active | Legal Secretary | Secrétaire | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
NORTH EAST PROMENADERS AGAINST CANCER LIMITED | 03 févr. 1995 | 17 mars 1995 | Dissoute | Legal Secretary | Secrétaire | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | |
NORTH EAST PROMENADERS AGAINST CANCER LIMITED | 03 févr. 1995 | 17 mars 1995 | Dissoute | Legal Secretary | Administrateur | Alliance House Hood Street NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0