• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • Eileen Theresa ROGAN

    Personne physique

    Titre
    PrénomEileen
    Deuxième prénomTheresa
    Nom de familleROGAN
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif0
    Inactif0
    Démissionné27
    Total27

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    WARD HADAWAY INCORPORATIONS LIMITED07 juil. 199931 juil. 2016DissouteAdministrator Secrétaire
    Sandgate House 102 Quayside
    Newcastle Upon Tyne
    NE1 3DX Tyne & Wear
    British
    WARD HADAWAY INCORPORATIONS LIMITED07 juil. 199918 sept. 2008DissouteAdministrator Administrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    SWIFT BRAKE & CLUTCH LIMITED14 juil. 199920 août 1999ActiveLegal SecretarySecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    SWIFT BRAKE & CLUTCH LIMITED14 juil. 199920 août 1999ActiveLegal SecretaryAdministrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    DATAFORM (MIDLANDS) LIMITED26 août 199715 déc. 1997DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    DATAFORM (MIDLANDS) LIMITED26 août 199715 déc. 1997DissouteLegal SecretarySecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    ARGONAUTICS LIMITED29 juin 199518 oct. 1996DissouteLegal SecretarySecrétaire
    34 Bondene Avenue West
    Felling
    NE10 9NL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    ARGONAUTICS LIMITED29 juin 199518 oct. 1996DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    34 Bondene Avenue West
    Felling
    NE10 9NL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    TEAMS ENTERPRISE PARTNERSHIP LIMITED28 juin 199623 juil. 1996DissouteSecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    AUDUS NOBLE LIMITED27 déc. 199510 mai 1996DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    AUDUS NOBLE LIMITED27 déc. 199510 mai 1996DissouteLegal SecretarySecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    RCL INDUSTRIES LIMITED27 déc. 199515 févr. 1996DissouteLegal SecretarySecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    RCL INDUSTRIES LIMITED27 déc. 199515 févr. 1996DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    CENTRELAND PARTNERSHIPS LIMITED28 nov. 199518 janv. 1996LiquidationLegal SecretarySecrétaire
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    CENTRELAND PARTNERSHIPS LIMITED28 nov. 199518 janv. 1996LiquidationLegal SecretaryAdministrateur
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    YORKSHIRE LAVENDER LIMITED15 août 199518 oct. 1995LiquidationCompany SecretarySecrétaire
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    YORKSHIRE LAVENDER LIMITED15 août 199518 oct. 1995LiquidationCompany SecretaryAdministrateur
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    CHRISTISON TECHNOLOGY GROUP LIMITED29 juin 199511 oct. 1995DissouteLegal SecretarySecrétaire
    34 Bondene Avenue West
    Felling
    NE10 9NL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    CHRISTISON TECHNOLOGY GROUP LIMITED29 juin 199511 oct. 1995DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    34 Bondene Avenue West
    Felling
    NE10 9NL Gateshead
    Tyne & Wear
    British
    WALLACE LANDSCAPING LIMITED28 mars 199508 août 1995DissouteCompany SecretarySecrétaire
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    WALLACE LANDSCAPING LIMITED28 mars 199508 août 1995DissouteCompany SecretaryAdministrateur
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    GAS-TEC LIMITED28 mars 199507 juin 1995DissouteCompany SecretarySecrétaire
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    GAS-TEC LIMITED28 mars 199507 juin 1995DissouteCompany SecretaryAdministrateur
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    BDW TRADING LIMITED03 févr. 199525 mars 1995ActiveLegal SecretaryAdministrateur
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    BDW TRADING LIMITED03 févr. 199525 mars 1995ActiveLegal SecretarySecrétaire
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    NORTH EAST PROMENADERS AGAINST CANCER LIMITED03 févr. 199517 mars 1995DissouteLegal SecretarySecrétaire
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British
    NORTH EAST PROMENADERS AGAINST CANCER LIMITED03 févr. 199517 mars 1995DissouteLegal SecretaryAdministrateur
    Alliance House Hood Street
    NE1 6LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0