Stephen John HOLDER
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Stephen |
| Deuxième prénom | John |
| Nom de famille | HOLDER |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 4 |
| Démissionné | 48 |
| Total | 56 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPS AUTOMOTIVE LIMITED | 22 juin 2006 | Active | Secrétaire | Studio 2 50-54 St Pauls Square B3 1QS Birmingham C/O Holder Blackthorn Llp United Kingdom | British | |||
| WPS PROCESSING LIMITED | 22 juin 2006 | Active | Secrétaire | Studio 2 50-54 St Pauls Square B3 1QS Birmingham C/O Holder Blackthorn Llp United Kingdom | British | |||
| DENMART PROPERTIES LTD | 20 avr. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | |||
| GWP PROPERTIES LIMITED | 19 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | |||
| WPSI GROUP LIMITED | 24 févr. 2003 | Active | Secrétaire | Studio 2 50 -54 St. Pauls Square B3 1QS Birmingham C/O Holder Blackthorn Llp United Kingdom | British | |||
| FN NEUHOFER LIMITED | 01 oct. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | |||
| AFT-AUTOMATION AND CONVEYING SYSTEMS UK LIMITED | 22 sept. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | |||
| WARDCROP ASSURED TENANCIES LIMITED | Active | Administrateur | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham | England | British | |||
| EFAFLEX UK LIMITED | 30 août 2012 | 30 avr. 2023 | Active | Administrateur | And 6 Cedar Court Halesfield 17 TF7 4PF Telford 5 Shropshire England | England | British | |
| EFAFLEX UK LIMITED | 31 mai 2006 | 30 avr. 2023 | Active | Secrétaire | And 6 Cedar Court Halesfield 17 TF7 4PF Telford 5 Shropshire | British | ||
| EAGLE PLASTICS LIMITED | 30 avr. 2002 | 08 mars 2023 | Dissoute | Secrétaire | Charter Point Way LE65 1NF Ashby-De-La-Zouch 14 England | British | ||
| EAGLE PLASTICS LIMITED | 31 mars 1994 | 08 mars 2023 | Dissoute | Administrateur | Charter Point Way LE65 1NF Ashby-De-La-Zouch 14 England | England | British | |
| ETESIA U.K. LIMITED | 04 févr. 1993 | 30 nov. 2020 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham | British | ||
| LEIPOLD (UK) LIMITED | 14 juil. 1994 | 04 nov. 2019 | Dissoute | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham | British | ||
| PROPBROOK LIMITED | 28 févr. 2008 | 01 mai 2019 | Liquidation | Secrétaire | Holder Blackthorn Blackthorn House B3 1RL St Pauls Square Birmingham | British | ||
| FISHER LEAK GROUP LIMITED | 09 janv. 2008 | 01 mai 2019 | Active | Secrétaire | St Pauls Square B3 1RL Birmingham Blackthorn House West Midlands | British | ||
| LEAKSYS LIMITED | 27 nov. 2006 | 01 mai 2019 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| FISHER LEAK AUTOMATION LIMITED | 27 nov. 2006 | 01 mai 2019 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| ILLSTON & ROBSON LIMITED | 25 avr. 2003 | 31 oct. 2018 | Active | Secrétaire | c/o Holder Blackthorn Llp 1 Mary Ann Street St Pauls Square B3 1RL Birmingham Blackthorn House England | British | ||
| TOX-PRESSOTECHNIK LIMITED | 23 sept. 2004 | 27 sept. 2018 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham | British | ||
| HUMMEL LTD | 04 avr. 2006 | 20 août 2018 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| EISENMANN U.K. LIMITED | 03 sept. 2001 | 20 août 2018 | En administration | Secrétaire | c/o Holder Blackthorn Llp 1 Mary Ann Street St Pauls Square B3 1RL Birmingham Blackthorn House England | British | ||
| BRUNO SAINT HILAIRE UK LIMITED | 01 juil. 2001 | 20 août 2018 | Dissoute | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| SYSPAL FINANCIAL LIMITED | 18 déc. 2003 | 01 avr. 2018 | Active | Secrétaire | c/o Holder Blackthorn Llp Mary Ann Street St Pauls Square B3 1RL Birmingham Blackthorn House England | British | ||
| SYSPAL SERVICES LIMITED | 01 juin 2000 | 01 avr. 2018 | Active | Secrétaire | c/o Holder Blackthorn Llp Mary Ann Street St Pauls Square B3 1RL Birmingham Blackthorn House England | British | ||
| GATC BIOTECH LIMITED | 27 nov. 2003 | 07 déc. 2017 | Dissoute | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| HOLDER BLACKTHORN LLP | 27 juin 2002 | 30 juin 2017 | Active | Membre désigné de la LLP | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | United Kingdom | ||
| FOERSTER UK LIMITED | 01 août 2001 | 21 juin 2017 | Active | Secrétaire | Blackthorn House St Pauls Square B3 1RL Birmingham West Midlands | British | ||
| WESTGATE STAINLESS AND ALLOYS LIMITED | 14 mars 2006 | 06 mai 2011 | Active | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| CHRISTMAS MARKETS LOEWENTHAL LIMITED | 28 sept. 2007 | 18 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| CHRISTMAS MARKETS UK LIMITED | 28 sept. 2007 | 18 nov. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| WILLIAM COLEBY (FINANCIAL SERVICES) LTD | 06 sept. 2007 | 21 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| HYDRO PHYSIO LIMITED | 09 mars 2006 | 01 avr. 2009 | Active | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| SYSPAL HOLDINGS LIMITED | 18 déc. 2003 | 01 avr. 2009 | Active | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British | ||
| TECHNIK TECHNOLOGY LIMITED | 22 mars 2002 | 01 avr. 2009 | Active | Secrétaire | Devon Lodge 118 The Boulevard B73 5JG Sutton Coldfield West Midlands | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0