Gerard Patrick PANTING
Personne physique
Titre | Dr |
---|---|
Prénom | Gerard |
Deuxième prénom | Patrick |
Nom de famille | PANTING |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 11 |
Total | 15 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGUCKIN MORGAN LTD | 21 déc. 2015 | Dissoute | Medico-Legal Advisor | Administrateur | Marshalls Heath Lane AL4 8HS Wheathampstead Waters Green Herts United Kingdom | United Kingdom | British | |
ORTHOPAEDIC SPECIALISTS INDEMNITY SCHEME LTD | 04 sept. 2014 | Dissoute | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blighs Walk TN13 1DB Sevenoaks 7 England | United Kingdom | British | |
HAND AND UPPER LIMB SPECIALISTS INDEMNITY SCHEME LTD | 12 avr. 2010 | Dissoute | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blackhall Lane TN15 0HP Sevenoaks The Garden House Kent England | United Kingdom | British | |
TWG ELEARNING LTD | 10 avr. 2006 | Dissoute | Registered Medical Practitione | Administrateur | Marshalls Heath Lane AL4 8HS Wheathampstead Waters Green Hertfordshire | United Kingdom | British | |
ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SPECIALISTS INDEMNITY SCHEME LTD | 17 mai 2011 | 31 déc. 2021 | Active | Registered Medical Practitioner | Administrateur | 11c Kingswood Road Hampton Lovett WR9 0QH Droitwich Oakmoore Court England | United Kingdom | British |
PRIVATE HEALTHCARE INFORMATION NETWORK LIMITED | 01 avr. 2015 | 31 déc. 2020 | Active | Registered Medical Practioner | Administrateur | Cavendish Square W1G 0AN London 11 England | United Kingdom | British |
GYNAECOLOGISTS INDEMNITY SCHEME LTD | 16 avr. 2014 | 13 janv. 2018 | Dissoute | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blackhall Lane TN15 0HP Sevenoaks Garden House England | United Kingdom | British |
SURGICAL INDEMNITY SCHEME LIMITED | 08 avr. 2011 | 24 janv. 2017 | Active | Registered Medical Practitioner | Administrateur | 35/43 Lincolns Inn Fields WC2A 3PE London Co Asgbi England | United Kingdom | British |
AOO SPECIALIST INDEMNITY SCHEME LTD | 20 juil. 2012 | 14 juil. 2016 | Active | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blighs Walk TN13 1DB Sevenoaks 7 Kent England | United Kingdom | British |
SPECIALIST PROFESSIONAL INDEMNITY SERVICES LTD | 27 nov. 2009 | 06 févr. 2016 | Dissoute | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blighs Walk TN13 1DB Sevenoaks 7 Kent | United Kingdom | British |
TWG RESOURCES LTD | 18 févr. 2003 | 06 févr. 2016 | Dissoute | Medical Practitioner | Administrateur | Marshalls Heath Lane AL4 8HS Wheathampstead Waters Green Hertfordshire | United Kingdom | British |
PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGEONS INDEMNITY SCHEME LTD | 09 déc. 2009 | 25 nov. 2015 | Active | Registered Medical Practitioner | Administrateur | Blighs Walk TN13 1DB Sevenoaks 7 Kent England | United Kingdom | British |
ISIS INDEMNITY SCHEME LTD | 01 févr. 2011 | 05 janv. 2015 | Active | Registered Medical Practitioner | Administrateur | c/o Walton Paige Accountants 2 Lime Walk Headington OX3 7DZ Oxford 11 Lime Tree Mews England | United Kingdom | British |
AK HAMILTON LIMITED | 28 sept. 2004 | 22 août 2007 | Dissoute | Doctor | Administrateur | Marshalls Heath Lane AL4 8HS Wheathampstead Waters Green Hertfordshire | United Kingdom | British |
TWG RESOURCES LTD | 06 avr. 2004 | 31 janv. 2005 | Dissoute | Medical Practitioner | Secrétaire | Marshalls Heath Lane AL4 8HS Wheathampstead Waters Green Hertfordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0