Timothy John Edward CHURCH
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Timothy |
Deuxième prénom | John Edward |
Nom de famille | CHURCH |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 2 |
Démissionné | 10 |
Total | 16 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO TRADING 2021 LIMITED | 14 avr. 2021 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London The Halo Trust | England | British | |
THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | 19 sept. 2018 | Active | Director | Administrateur | Whisby Way LN6 3LQ Lincoln Eyre Court England | England | British | |
TIEBE LIMITED | 08 févr. 2017 | Active | Director | Administrateur | W8 6PP London 50 Scarsdale Villas England | England | British | |
AID TO THE CHURCH IN NEED (UNITED KINGDOM) | 31 janv. 2017 | Active | Company Director | Administrateur | 12-14 Benhill Avenue Sutton SM1 4DA Surrey | England | British | |
LSIM ASSETS LIMITED | 31 mars 2011 | Dissoute | None | Administrateur | Jermyn Street SW1Y 4UH London 1 United Kingdom | England | British | |
COMPASS MCSGI LIMITED | 28 févr. 2011 | Dissoute | President | Administrateur | Scarsdale Villas W8 6PP London 50 United Kingdom | England | British | |
GOLDFINGER FACTORY ONE C.I.C. | 08 juil. 2024 | 12 sept. 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Golborne Road W10 5PG London 13-15 England | England | British |
THE HALO TRUST | 10 juin 2016 | 20 déc. 2023 | Active | Company Director | Administrateur | c/o The Company Secretary Carronfoot DG3 5BF Thornhill The Halo Trust Dumfriesshire United Kingdom | England | British |
LIMITED LIFE ASSETS SERVICES LIMITED | 09 mars 2011 | 20 oct. 2022 | Liquidation | None | Administrateur | Jermyn Street SW1Y 4UH London 1 United Kingdom | England | British |
LIMITED LIFE ASSETS MASTER LIMITED | 08 mars 2011 | 20 oct. 2022 | Liquidation | None | Administrateur | Jermyn Street SW1Y 4UH London 1 United Kingdom | England | British |
MUSTARD SEED IMPACT LTD | 30 août 2018 | 01 janv. 2022 | Active | Company Director | Administrateur | 11/15 William Road NW1 3ER London Acre House United Kingdom | England | British |
MIO PARTNERS (UK) LIMITED | 23 août 2007 | 01 janv. 2017 | Active | Director | Administrateur | 50 Scarsdale Villas W8 6PP London | England | British |
ENTERPRISE EDUCATION TRUST | 01 juin 2006 | 05 nov. 2007 | Dissoute | Investment Director | Administrateur | 50 Scarsdale Villas W8 6PP London | England | British |
ERG WIND MEG 4 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 01 déc. 2004 | 06 déc. 2006 | Active | Membre de la LLP | 50 Scarsdale Villas W8 6PP London | England | ||
ERG WIND MEG 3 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP | 05 nov. 2004 | 06 déc. 2006 | Active | Membre de la LLP | 50 Scarsdale Villas W8 6PP London | England | ||
ADVENT MANAGEMENT LIMITED | 07 juin 1991 | Dissoute | Secrétaire | 50 Scarsdale Villas W8 6PP London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0