Keith Terry OTT
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Keith |
Deuxième prénom | Terry |
Nom de famille | OTT |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 52 |
Total | 52 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEST ENERGY LIMITED | 01 déc. 2005 | 21 déc. 2007 | En administration | Lawyer | Administrateur | Mas Dou Gaou Quartier Vignes De Greaux 13520 Maussane Les Alpilles France | British | |
BLUE OCEAN ASSOCIATES LIMITED | 29 oct. 2003 | 21 déc. 2007 | Dissoute | Lawyer | Administrateur | Mas Dou Gaou Quartier Vignes De Greaux 13520 Maussane Les Alpilles France | British | |
PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | 28 déc. 2000 | 30 janv. 2004 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | 28 déc. 2000 | 30 janv. 2004 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
QUANTEGY EUROPA LIMITED | 21 mars 2000 | 30 janv. 2004 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
PAUL, HASTINGS, JANOFSKY & WALKER LIMITED | 23 juil. 1997 | 30 janv. 2004 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
PAUL, HASTINGS, JANOFSKY & WALKER LIMITED | 23 juil. 1997 | 30 janv. 2004 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
HARBOR CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED | 20 mai 1999 | 30 déc. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
NEW WAVE IT MANAGEMENT AND SERVICES LIMITED | 23 oct. 2000 | 22 juil. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
LODESTONE MRI LIMITED | 13 mars 1998 | 27 sept. 2001 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
LODESTONE IMAGING LIMITED | 27 sept. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |||
CONCORDE EUROPE LIMITED | 18 avr. 2001 | 27 avr. 2001 | Active | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
BLUE OCEAN ASSOCIATES LIMITED | 06 juil. 1993 | 02 avr. 2001 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
EUCLID ENERGY LIMITED | 24 mai 2000 | 13 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
BLUE OCEAN ENERGY LIMITED | 29 oct. 1999 | 13 mars 2001 | Dissoute | Lawyer | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
BLUE OCEAN ENERGY LIMITED | 29 oct. 1999 | 13 mars 2001 | Dissoute | Lawyer | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
FUTURELINK EUROPE LIMITED | 20 déc. 1999 | 16 janv. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
BLUE OCEAN INTERNATIONAL LIMITED | 19 janv. 2000 | 21 nov. 2000 | Active | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
RUBICON EUROPE LIMITED | 25 févr. 2000 | 26 févr. 2000 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
RUBICON EUROPE LIMITED | 25 févr. 2000 | 26 févr. 2000 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
BLUE OCEAN INTERNATIONAL LIMITED | 19 janv. 2000 | 20 janv. 2000 | Active | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
PREMIERE GLOBAL SERVICES (GB) LIMITED | 16 juil. 1997 | 10 août 1999 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LIMITED | 13 avr. 1999 | 15 avr. 1999 | Active | Lawyer | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LIMITED | 13 avr. 1999 | 15 avr. 1999 | Active | Lawyer | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
LODESTONE MRI LIMITED | 13 mars 1998 | 08 avr. 1998 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
CASTLEGATE 762 LIMITED | 13 mars 1998 | 18 mars 1998 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
CASTLEGATE 762 LIMITED | 13 mars 1998 | 18 mars 1998 | Dissoute | Attorney | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
KIDS PROPERTIES LIMITED | 23 août 1994 | 26 août 1997 | Dissoute | Lawyer | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
KIDS (WARRINGTON AND LUTON) LIMITED | 02 sept. 1992 | 26 août 1997 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED | 21 févr. 1997 | 18 août 1997 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
PREMIERE GLOBAL SERVICES (GB) LIMITED | 16 juil. 1997 | 04 août 1997 | Dissoute | Attorney | Administrateur | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
VISIBILITY EUROPE LIMITED | 18 sept. 1996 | 23 juin 1997 | Active | Lawyer | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
LXE (UK) LTD. | 16 juil. 1996 | 23 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | ||
BONIFACE ENGINEERING LIMITED | 10 avr. 1996 | 23 juin 1997 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British | |
FMH CONVEYORS INTERNATIONAL LIMITED | 02 déc. 1994 | 23 juin 1997 | Active | Lawyer | Secrétaire | 50 Gayton Road Hampstead NW3 1TU London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0