Wendy Jill SHARP - Page 5
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Wendy |
Deuxième prénom | Jill |
Nom de famille | SHARP |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 16 |
Inactif | 100 |
Démissionné | 66 |
Total | 182 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT ELECTRONICS EUROPE LIMITED | 16 mars 2007 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road Weybridge KT13 9XB Surrey | British | ||
WELWYN COMPONENTS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Welwyn Electronics Park Bedlington NE22 7AA Northumberland | British | ||
CICOR UK PROPERTIES LTD | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
CRYSTALATE ELECTRONICS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
COMMENDSHAW LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road Weybridge Surrey | British | |
AUTOMOTIVE ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
DALE ELECTRIC INTERNATIONAL LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge | British | |
MIDLAND ELECTRONICS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
TT GROUP LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
ABTEST LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Tregwilym Industrial Estate Rogerstone NP10 9YA Newport Unit 1 Gwent United Kingdom | British | ||
CICOR NEWPORT LTD | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Tregwilym Industrial Estate Rogerstone, NP10 9YA Newport Gwent | British | ||
DELTIGHT WASHERS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
LINTON AND HIRST GROUP LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House, 12-18 Queens Road Weybridge KT13 9XB Surrey | British | |
TT POWER SOLUTIONS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
TTG NOMINEES LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
MMG LINTON AND HIRST LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
TT ASIA HOLDINGS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Hedges Jackmans Lane, St Johns GU21 7RL Woking Surrey | British | |
A.B. ELECTRONIC COMPONENTS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
BI TECHNOLOGIES LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Clive House 12 Queens Road Weybridge KT13 9XB Surrey | British | ||
TT ELECTRONICS GROUP HOLDINGS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
TTG INVESTMENTS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road Weybridge Surrey , Kt 13 9xb | British | |
WELWYN ELECTRONICS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
WOLSEY COMCARE LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | |
HALOSENSOR ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | ||
AB CONNECTORS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Secrétaire | Abercynon Mountain Ash CF45 4SF Rhondda Cynon Taff | British | ||
TT AUTOMOTIVE ELECTRONICS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Clive House Surrey England | British | |
RODCO LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 janv. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey | British | ||
SEMELAB LIMITED | 21 août 2008 | 30 janv. 2013 | Liquidation | Secrétaire | Coventry Road LE17 4JB Lutterworth Leicestershire | British | ||
OTTOMOTORES NOMINEES LIMITED | 08 sept. 2011 | 08 déc. 2012 | Active | Company Secretary | Administrateur | 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Clive House 12-18 Surrey England | United Kingdom | British |
GENERAC GLOBAL UK LIMITED | 27 oct. 2008 | 08 déc. 2012 | Active | Company Secretary | Administrateur | East Smithfield E1W 1AW London 46-48 | United Kingdom | British |
GENERAC GLOBAL UK LIMITED | 01 déc. 2006 | 08 déc. 2012 | Active | Company Secretary | Secrétaire | East Smithfield E1W 1AW London 46-48 | British | |
TT ELECTRONICS PLC | 01 janv. 2007 | 04 déc. 2012 | Active | Secrétaire | Clive House 12-18 Queens Road KT13 9XB Weybridge Surrey, | British | ||
DALE POWER SOLUTIONS LIMITED | 01 déc. 2006 | 30 juil. 2012 | Active | Secrétaire | Salter Road Eastfield Industrial Estate YO11 3DU Scarborough | British | ||
AEI COMPOUNDS LIMITED | 01 déc. 2006 | 11 juil. 2011 | Active | Secrétaire | CT13 9LY Sandwich Sandwich Industrial Estate Kent United Kingdom | British | ||
PSM INTERNATIONAL FASTENERS LIMITED | 01 déc. 2006 | 15 déc. 2010 | Liquidation | Secrétaire | Ferry Lane Pembroke Dock SA71 4RG Pembroke Dyfed | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0