Christopher Mark BRANDWOOD
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Christopher |
| Deuxième prénom | Mark |
| Nom de famille | BRANDWOOD |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 16 |
| Total | 17 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRABNERS CHAFFE STREET LIMITED | 20 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire | King Street M2 4LQ Manchester 5th Floor 55 | British | |||
| DAVID RUSSELL (KENDAL) LIMITED | 09 déc. 2009 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor 55 | British | ||
| DAVID RUSSELL (KENDAL) LIMITED | 09 déc. 2009 | Dissoute | Secrétaire | King Street M2 4LQ Manchester Fifth Floor 55 | British | |||
| BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC | 24 sept. 2004 | 17 janv. 2008 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| DGP INTERNATIONAL LTD | 22 déc. 1998 | 07 avr. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| SENIOR RESPONSE LIMITED | 22 déc. 1998 | 02 févr. 1999 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| BAINBRIDGE ENTERPRISES (UK) LIMITED | 22 déc. 1998 | 02 févr. 1999 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NICHOLL-SMITH HORTICULTURAL LIMITED | 17 nov. 1998 | 24 déc. 1998 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NIKAL LTD | 16 nov. 1998 | 23 déc. 1998 | En administration | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| MARPLACE (NUMBER 434) LIMITED | 17 nov. 1998 | 16 déc. 1998 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| THARLMAN LIMITED | 20 juil. 1995 | 16 mai 1996 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| GSD (CORPORATE) LIMITED | 20 juil. 1995 | 11 mars 1996 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| NCC GROUP ESCROW LIMITED | 20 juil. 1995 | 06 mars 1996 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| SGL CARBON FIBERS LIMITED | 06 juin 1989 | 12 avr. 1995 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | ||
| R.K. TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | 12 avr. 1995 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | |||
| KBC PROCESS TECHNOLOGY (MIDDLE EAST) LIMITED | 20 févr. 1993 | Active | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British | |||
| LINNHOFF MARCH INTERNATIONAL | 19 févr. 1993 | Dissoute | Secrétaire | Brook House 77 Fountain Street M2 2EE Manchester | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0