Angelique Elizabeth LILLEY
Personne physique
| Titre | Mrs. |
|---|---|
| Prénom | Angelique |
| Deuxième prénom | Elizabeth |
| Nom de famille | LILLEY |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 21 |
| Démissionné | 46 |
| Total | 67 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTONO BUSINESS LIMITED | 27 févr. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | 43 Bedford Street WC2E 9HA London Office 11 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| DOWLING PARTNERS LTD. | 08 févr. 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | 43 Bedford Street WC2E 9HA London Office 11 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| LEROY MARLIN LIMITED | 23 oct. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| RITTINGER TECHNOLOGY LTD. | 23 oct. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| OLDOK TRADE LTD. | 08 oct. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| KADNEY ENTERPRISES LLP | 17 sept. 2012 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 67 Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House Cheshire | New Zealand | |||
| TAGOS ENTERPRISES LLP | 17 sept. 2012 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 67 Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House Cheshire | New Zealand | |||
| I P C ASSOCIATES LLP | 04 sept. 2012 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 145-157 St. John Street EC1V 4PW London I P C Associates Llp England | New Zealand | |||
| ENTLEY VENTURES LTD. | 20 juin 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| TALBERG TECHNOLOGY LTD. | 06 juin 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| BEST HOLIDAYS TRAVEL LTD. | 23 mai 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| LOTHUS CORPORATION LTD. | 23 avr. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| SUNCRAFT ENTERPRISES INC. LTD. | 12 avr. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| BRITIKO EXIM LTD. | 30 mars 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| LARSON COMPLEX LTD. | 29 mars 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| YELLSITE INTRO LTD. | 23 mars 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| VINIMILEX LLP | 22 févr. 2012 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 67 Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House Cheshire | New Zealand | |||
| GOLDEN GATE DEVELOPMENT PARTNERS LIMITED | 27 janv. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| FORTRAN PARTNERS LTD. | 20 janv. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| HANSFORD TECHNOLOGY LTD. | 20 janv. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander | |
| CARSON INDUSTRIES LIMITED | 27 déc. 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | Suite 8 176 Finchley Road NW3 6BT London | New Zealand | New Zealander | |
| GROWNOWSYS LLP | 31 juil. 2012 | 28 févr. 2018 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 67 Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House Cheshire | New Zealand | ||
| GI & T INTERNATIONAL LLP | 22 févr. 2012 | 23 févr. 2018 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | 67 Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House Cheshire | New Zealand | ||
| GROUBER TRADERS LLP | 08 oct. 2012 | 06 déc. 2017 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Wellington Road North SK4 2LP Stockport Minshull House/67 Cheshire | New Zealand | ||
| BEWHHART LTD. | 08 mars 2012 | 08 mars 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| ALTEX STOCKHOLD LIMITED | 09 déc. 2011 | 09 déc. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Finchley Road Office 8 NW3 6BT London 176 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| TRANSLOG BUSINESS LTD. | 20 juin 2012 | 26 mai 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| INTRATECH ENGINEERING LTD. | 01 mai 2012 | 30 avr. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| MARISTELLA INVESTMENT LIMITED | 19 avr. 2013 | 01 avr. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| BOLLARD INTEGRO LTD. | 23 avr. 2012 | 31 mars 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| WENTECO INTER LTD. | 30 mars 2012 | 30 mars 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| JET-TECH INDUSTRIES LTD. | 23 mars 2012 | 20 mars 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| ANDALIDI ASSETS LTD. | 07 déc. 2012 | 03 mars 2014 | Active | Director | Administrateur | 43 Bedford Street WC2E 9HA London Office 11 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| ALVIO TRADING LIMITED | 20 août 2012 | 03 mars 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | Bedford Street Office 11 WC2E 9HA London 43 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
| GOLDCRAFT HV INSTALLATION LTD. | 05 févr. 2013 | 26 févr. 2014 | Dissoute | Director | Administrateur | 43 Bedford Street WC2E 9HA London Office 11 United Kingdom | New Zealand | New Zealander |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0