Peter John WELLER
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Peter |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | WELLER |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 16 |
Total | 17 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAPPAWOO LTD | 01 mars 2014 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Anvil Way CM12 0XY Billericay 11 Essex England | England | British | |
CROMWELL HEALTH GROUP LIMITED | 31 mars 2021 | 24 juil. 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Cromwell Hospital Cromwell Road SW5 0TU London | England | British |
MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED | 30 juin 2020 | 24 juil. 2024 | Active | Finance Director | Administrateur | Cromwell Hospital Cromwell Road SW5 0TU London | England | British |
CROMWELL HOSPITAL RETIREMENT PLAN TRUSTEE LIMITED | 03 juin 2021 | 20 juin 2022 | Active | Finance Director Of Bupa Cromwell Hospital | Administrateur | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | England | British |
BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE LIMITED | 03 nov. 2017 | 28 févr. 2019 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 33 Holborn EC1N 2HT London 7th Floor United Kingdom | England | British |
CACTUS CENTRAL LIMITED | 29 juin 2017 | 28 févr. 2019 | Liquidation | Accountant | Administrateur | 33 Holborn EC1N 2HT London 7th Floor England | England | British |
CACTUS TRADING SOUTH LIMITED | 29 juin 2017 | 28 févr. 2019 | Liquidation | Accountant | Administrateur | 33 Holborn EC1N 2HT London 7th Floor England | England | British |
CACTUS TRADING NORTH LIMITED | 29 juin 2017 | 28 févr. 2019 | Liquidation | Accountant | Administrateur | 33 Holborn EC1N 2HT London 7th Floor England | England | British |
ENABLES IT LIMITED | 01 nov. 2012 | 13 août 2013 | Active | Accountant | Administrateur | Mole Business Park Randalls Road KT22 7BA Leatherhead Unit 5 Surrey England | England | British |
FIX IT WORLDWIDE LIMITED | 09 déc. 2011 | 13 août 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | c/o Nexus Management Moorgate EC2M 6UR London 120 Uk | England | British |
FIX IT WORLDWIDE LIMITED | 02 mai 2006 | 13 août 2013 | Dissoute | Secrétaire | Mole Business Park Randalls Road KT22 7BA Leatherhead Unit 5 Surrey England | British | ||
TACTIC HUB LIMITED | 03 févr. 2004 | 13 août 2013 | Active | Accountant | Secrétaire | 11 Anvil Way CM12 0XY Billericay Essex | British | |
ENABLES IT (UK) LIMITED | 13 août 2003 | 13 août 2013 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | Mole Business Park Randalls Road KT22 7BA Leatherhead Unit 5 Surrey | British | |
ENABLES IT (UK) LIMITED | 13 août 2003 | 13 août 2013 | Dissoute | Accountant | Administrateur | Mole Business Park Randalls Road KT22 7BA Leatherhead Unit 5 Surrey | England | British |
PC MEDICS GROUP LIMITED | 01 août 2002 | 13 août 2013 | Dissoute | Company Director | Administrateur | 11 Anvil Way CM12 0XY Billericay Essex | England | British |
TACTIC HUB LIMITED | 29 janv. 2001 | 13 août 2013 | Active | Accountant | Administrateur | 11 Anvil Way CM12 0XY Billericay Essex | England | British |
BENTLEY GOLF CLUB LIMITED | 29 avr. 2004 | 20 août 2004 | Active | Accountant | Administrateur | 69 Berwick Road RM13 9QL Rainham Essex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0