Paul James WILSON
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Paul |
Deuxième prénom | James |
Nom de famille | WILSON |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 66 |
Total | 66 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCKISER | 25 juil. 2000 | 31 déc. 2001 | Liquidation | Company Secretary | Administrateur | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
BENCKISER | 25 juil. 2000 | 31 déc. 2001 | Liquidation | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
RECKITT BENCKISER CORPORATE SERVICES LIMITED | 03 août 2000 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED | 28 juin 2000 | 28 déc. 2001 | Active | Co Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
GLASGOW SQUARE LIMITED | 12 nov. 1999 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
R&C NOMINEES ONE LIMITED | 17 sept. 1999 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
R&C NOMINEES TWO LIMITED | 17 sept. 1999 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
R&C NOMINEES LIMITED | 06 nov. 1998 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
RECKITT & COLMAN HOLDINGS LIMITED | 06 nov. 1998 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
RECKITT & COLMAN PENSION TRUSTEE LIMITED | 21 mai 1998 | 28 déc. 2001 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
LINDEN GERMANY A LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT BENCKISER EXPATRIATE SERVICES LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
LINDEN GERMANY B LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
SONET DORMANT COMPANY NO. 1 LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
LLOYDS PHARMACEUTICALS | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
HAMOL LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
HOWARD LLOYD & COMPANY,LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT COLMAN CHISWICK (OTC) LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT & SONS LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT & COLMAN (UK) LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
ERH PROPACK LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT & COLMAN PENSION FUND (NOMINEES) LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
RECKITT & COLMAN TRUSTEE SERVICES LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
HELPCENTRAL LIMITED | 01 mars 1996 | 28 déc. 2001 | Liquidation | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
SCHULKE & MAYR UK LIMITED | 01 mars 1996 | 06 sept. 1996 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |
HUDSON & HILL LIMITED | 24 sept. 1993 | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
MOTORWAY SERVICES LIMITED | 08 mai 1992 | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
TRAVELODGE HOTELS LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |||
PROCUREMENT 2U LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |||
WHEELER'S RESTAURANTS LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | |||
WHEELER'S RESTAURANTS LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Company Secretary | Administrateur | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
COMPASS CATERING SERVICES LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Company Secretary | Administrateur | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | ||
EUREST UK LIMITED | 19 juin 1994 | Active | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0