Jonathan Peter Morris BIRD
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Jonathan |
| Deuxième prénom | Peter Morris |
| Nom de famille | BIRD |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 3 |
| Démissionné | 14 |
| Total | 17 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREHORSE ASSOCIATES LIMITED | 06 févr. 2015 | Dissoute | Director | Administrateur | New Square S40 1AH Chesterfield Dents Chambers Derbyshire England | United Kingdom | British | |
| DARLEY CONTRACTS LIMITED | 27 oct. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |||
| REGENERATE LIMITED | 01 déc. 2004 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British | |
| THE COMPLETE SUITE CO LIMITED | 13 nov. 2003 | 02 mars 2017 | Active | Secrétaire | Salisbury Crescent Newbold S41 8PP Chesterfield 8 Derbyshire | British | ||
| BRADLEY & HOWE FINANCIAL SERVICES LIMITED | 24 juin 2003 | 30 juin 2008 | Active | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| BRADLEY & HOWE FINANCIAL ASSOCIATES LIMITED | 24 juin 2003 | 30 juin 2008 | Active | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| JOHN DENT (CHEMISTS) LIMITED | 13 mars 2007 | 08 avr. 2008 | Liquidation | Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| NEW SQUARE PROPERTIES LIMITED | 25 févr. 2005 | 08 avr. 2008 | Active | Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| SAMUEL SHARP (CURRIERS) LIMITED | 21 juin 2006 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| JCS REALISATIONS LIMITED | 21 juin 2006 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| CLAYTON OF CHESTERFIELD LIMITED | 21 juin 2006 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Chartered Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| KIRBEX LIMITED | 20 mai 2002 | 01 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | ||
| DARLEY CONTRACTS LIMITED | 15 févr. 2005 | 26 oct. 2006 | Dissoute | Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| REGENERATE LIMITED | 01 déc. 2004 | 11 févr. 2005 | Dissoute | Accountant | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |
| I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED | 27 juil. 2002 | 07 sept. 2002 | Active | Accountant | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British | |
| I P COMMERCIAL SOLUTIONS LIMITED | 27 juil. 2002 | 07 sept. 2002 | Active | Accountant | Administrateur | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | United Kingdom | British |
| TRIO CONTRACTS LIMITED | 25 avr. 2000 | 02 mai 2000 | Dissoute | Secrétaire | 76 Rectory Lane Breadsall Village DE21 5LL Derby Derbyshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0