Judith Sandra EPSTEIN
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Judith |
| Deuxième prénom | Sandra |
| Nom de famille | EPSTEIN |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 2 |
| Inactif | 8 |
| Démissionné | 22 |
| Total | 32 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNCTION 10 TRADING LIMITED | 01 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| STARRS LIMITED | 01 nov. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| G.M.J. LIMITED | 01 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| MULTIPLE CONSULTANTS LIMITED | 09 oct. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| WESTLAND LIMITED | 09 oct. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| LONDON IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED | 10 janv. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| HOMECARE PRODUCTS LIMITED | 10 janv. 1997 | Liquidation | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| PINSON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 26 mars 1996 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| LONDON IMPORTS (UK) LIMITED | 16 mars 1995 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| MERETON PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 20 oct. 1994 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | |||
| TRAFALGAR BUSINESS CENTRE MANAGEMENT COMPANY (NO.2) LIMITED | 30 sept. 2001 | 30 juin 2013 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| BARKING WHOLESALE LIMITED | 09 oct. 1998 | 30 juin 2013 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| LONDON IMPORTS LIMITED | 16 mars 1995 | 30 juin 2013 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS CONSULTANCY LLP | 19 juin 2007 | 01 juil. 2011 | Active | Membre désigné de la LLP | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford | United Kingdom | ||
| J.A. PHILLIPS HOLDINGS LIMITED | 10 févr. 1995 | 20 sept. 2008 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| REGAL BRAND MANAGEMENT LIMITED | 01 janv. 1995 | 20 sept. 2008 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS ASSOCIATES LIMITED | 24 mars 2003 | 01 nov. 2004 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS ASSOCIATES LIMITED | 05 avr. 2002 | 24 mars 2003 | Active | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| J.A. PHILLIPS ASSOCIATES LIMITED | 05 avr. 1995 | 05 avr. 2002 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS ASSOCIATES LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Active | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| BARKING WHOLESALE LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Active | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| J.A. PHILLIPS HOLDINGS LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Active | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| REGAL BRAND MANAGEMENT LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Active | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| LONDON IMPORTS LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Dissoute | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| MULTIPLE CONSULTANTS LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Dissoute | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| WESTLAND LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Dissoute | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| LONDON IMPORTS (UK) LIMITED | 01 avr. 2000 | 12 oct. 2000 | Dissoute | Administrateur | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | United Kingdom | British | |
| G.M.J. LIMITED | 18 oct. 1996 | 28 janv. 1998 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| LONDON IMPORTS (UK) LIMITED | 09 août 1993 | 20 avr. 1994 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| LONDON IMPORTS LIMITED | 03 août 1992 | 26 mars 1994 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS HOLDINGS LIMITED | 20 août 1991 | 26 mars 1994 | Active | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British | ||
| J.A. PHILLIPS (WHOLESALE) LIMITED | 26 mars 1994 | Dissoute | Secrétaire | 13 Russell Gardens Ley Street IG2 7BY Ilford Essex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0