John Robert MILLIGAN
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | John |
| Deuxième prénom | Robert |
| Nom de famille | MILLIGAN |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 16 |
| Total | 18 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTSWOOD DEVELOPMENTS LIMITED | 02 août 2002 | Dissoute | Administrateur | Ballathie Estate Kinclaven, Stanley PH1 4QN Perth | Scotland | British | ||
| BALLATHIE ESTATES LIMITED | 14 nov. 1997 | Active | Administrateur | Ballathie Estate Kinclaven, Stanley PH1 4QN Perth | Scotland | British | ||
| BALLATHIE HOUSE HOTEL COMPANY LIMITED | 25 août 2005 | 13 déc. 2024 | Active | Administrateur | Ballathie Estate Kinclaven, Stanley PH1 4QN Perth | Scotland | British | |
| THE BALLATHIE FISHINGS TIMESHARE LIMITED | 24 sept. 2004 | 16 sept. 2022 | Active | Administrateur | Ballathie Estate Kinclaven, Stanley PH1 4QN Perth | Scotland | British | |
| ABERDEEN DEVELOPMENT CAPITAL PLC | 16 oct. 1998 | 30 avr. 2012 | Dissoute | Administrateur | George Street EH2 2DZ Edinburgh Ten | Scotland | British | |
| ADC ZEROS 2012 PLC | 20 mai 2005 | 16 sept. 2011 | Dissoute | Administrateur | George Street EH22 2DZ Edinburgh Ten | British | ||
| ADC ZEROS 2010 PLC | 20 mai 2005 | 16 sept. 2011 | Dissoute | Administrateur | George Street EH2 2DZ Edinburgh Ten | British | ||
| TAY RIVERS TRUST LTD. | 17 déc. 2005 | 08 févr. 2010 | Active | Administrateur | Ballathie Estate Kinclaven, Stanley PH1 4QN Perth | Scotland | British | |
| SCOTTISH ENTERPRISE GRAMPIAN | 06 avr. 1999 | 08 janv. 2002 | Active | Administrateur | Rue De La Vallee No 59-63 Apartments No 8-9 1000 Brussels Belgium | British | ||
| RGIT ETHOS HEALTH & SAFETY LIMITED | 25 févr. 1998 | 20 nov. 2000 | Dissoute | Administrateur | Rue De La Vallee No 59-63 Apartments No 8-9 1000 Brussels Belgium | British | ||
| JOINT VENTURE INTERNATIONAL LIMITED | 16 mai 1991 | 31 mai 2000 | Dissoute | Administrateur | 17 Fullarton Drive KA10 6LE Troon Ayrshire | British | ||
| PETROFAC FACILITIES MANAGEMENT GROUP LIMITED | 31 mai 2000 | Active | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British | |||
| ATLANTIC RESOURCING LIMITED | 01 juil. 1997 | 01 janv. 2000 | Active | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British | ||
| PLANT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 12 févr. 1992 | 01 janv. 2000 | Dissoute | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British | ||
| PETROFAC FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 01 janv. 2000 | Arrangement amiable | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British | |||
| ABERDEEN ENTERPRISE TRUST LIMITED | 14 mars 1994 | 27 oct. 1999 | Dissoute | Administrateur | 17 Fullarton Drive KA10 6LE Troon Ayrshire | British | ||
| SIBIR ENERGY LIMITED | 17 mars 1997 | 15 juin 1999 | Dissoute | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British | ||
| UNIVATION LIMITED | 08 août 1995 | 08 mai 1998 | Active | Administrateur | Scotswood 134 Bentinck Drive KA10 6JB Troon Ayrshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0