Gordon Stewart LUND
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Gordon |
Deuxième prénom | Stewart |
Nom de famille | LUND |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 10 |
Total | 14 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHERN RUBBER LTD | 05 sept. 2012 | Dissoute | Director | Administrateur | 14th Floor Southgate House SG1 1HG Stevenage Suite 3 England | United Kingdom | United Kingdom | |
VLJ ASSETS AND RECEIVABLES LIMITED | 04 août 2009 | Dissoute | Director | Administrateur | Southgate House St Georges Way SG1 1HG Stevenage Suite 3 14th Floor Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | |
GREYSTONE ASSETS LTD | 11 déc. 2008 | Dissoute | Director | Administrateur | 5 Arlington Court Whittle Way SG1 2FS Stevenage Suite 2, United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | |
OMNIA HOMES LIMITED | 27 mars 2006 | Dissoute | Director | Administrateur | 5 Arlington Court Whittle Way SG1 2FS Stevenage Suite 2 Beechwood House Hertfordshire England | United Kingdom | United Kingdom | |
LEONARD JAMES & CO LTD | 19 févr. 2009 | 01 janv. 2021 | Active | Director | Administrateur | 152-160 City Road EC1V 2NX London Kemp House England | United Kingdom | United Kingdom |
AFFINITY ASSOCIATES (JTA) LIMITED | 28 nov. 2008 | 16 sept. 2015 | Active | Director | Administrateur | 5 Arlington Court Whittle Way SG1 2FS Stevenage Suite 2 Beechwood House Hertfordshire England | United Kingdom | United Kingdom |
INN OR OUT LIMITED | 01 oct. 2010 | 24 déc. 2013 | Dissoute | None | Administrateur | St George's Way SG1 1HG Stevenage Suit 3 14th Floor Southgate House Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom |
HOST MANAGEMENT LTD | 23 juil. 2012 | 10 sept. 2013 | Liquidation | None | Administrateur | Clay End SG2 7JD Walkern Walkern Park Farm | United Kingdom | United Kingdom |
ENSEMBLE COMBINED SERVICES LIMITED | 03 déc. 2010 | 23 juil. 2012 | Liquidation | Director | Administrateur | 14th Floor Southgate House St Georges Way SG1 1HG Stevenage Suite 3 England | United Kingdom | United Kingdom |
MOORHAVEN MANAGEMENT LIMITED | 01 avr. 2004 | 01 juin 2007 | Active | Director | Administrateur | Banklands Farmhouse Clenchwarton PE34 4DB Kings Lynn | British | |
SATELLITE MEDIA PLC | 24 nov. 2004 | 01 mars 2005 | Dissoute | Director | Secrétaire | Flat 1 26/28 Bartholomew Square EC1V 3QH London England | British | |
SATELLITE MEDIA PLC | 24 nov. 2004 | 01 mars 2005 | Dissoute | Director | Administrateur | Flat 1 26/28 Bartholomew Square EC1V 3QH London England | British | |
INTELLIPLUS LIMITED | 12 août 1998 | 21 janv. 2000 | Active | Director | Administrateur | Banklands Farmhouse Clenchwarton PE34 4DB Kings Lynn | British | |
INTELLIPLUS LIMITED | 12 août 1998 | 21 janv. 2000 | Active | Director | Secrétaire | Banklands Farmhouse Clenchwarton PE34 4DB Kings Lynn | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0