Philip CATHERALL - Page 2
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Philip |
Nom de famille | CATHERALL |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 37 |
Démissionné | 41 |
Total | 78 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTERN RENEWABLES LIMITED | 14 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House Gloucestershire England | British | |||
ECO.NET (UK) LIMITED | 14 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | |||
DERIX VENTURES LIMITED | 13 déc. 2006 | 02 nov. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
LOCHNET SYSTEMS LIMITED | 13 déc. 2006 | 01 nov. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
MICROTRICITY LIMITED | 20 oct. 2005 | 25 sept. 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
ECOBANK LIMITED | 18 nov. 2004 | 25 sept. 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
CARBONAID LTD | 18 nov. 2004 | 25 sept. 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
ECOLECTRICITY LIMITED | 14 nov. 2003 | 04 sept. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
SANDY WIND TURBINE LIMITED | 30 avr. 2007 | 04 avr. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
DULATER HILL WIND PARK LIMITED | 28 nov. 2007 | 15 mars 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
DAGENHAM 2 WIND PARK LIMITED | 30 avr. 2007 | 15 mars 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
BICKER FEN ENERGY STORAGE LIMITED | 14 nov. 2003 | 15 mars 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
NEXGEN GROUP LIMITED | 14 déc. 2006 | 13 mars 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
BAMBERS WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 06 mars 2018 | Active | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire United Kingdom | British | ||
DUNDEE MERCHANT WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 31 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
WIND HOLDINGS NORD LIMITED | 06 juil. 2007 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
GALSWORTHY WIND PARK LIMITED | 02 mai 2007 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
FEN FARM SOLAR PARK LIMITED | 12 avr. 2007 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
CARDIFF WIND PARK LIMITED | 12 avr. 2007 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British | ||
KINGS LYNN WIND PARK LIMITED | 13 déc. 2006 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
WORKSOP WIND PARK LIMITED | 13 déc. 2006 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
FEN FARM WIND PARK LIMITED | 20 oct. 2005 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British | ||
BRISTOL PORT WIND PARK LIMITED | 20 oct. 2005 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British | ||
NEW POWER COMPANY LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
WESTERN WINDPOWER LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
SWAFFHAM WINDPARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
ECOTRICITY LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
ECOTRICITY (DALE VINCE) LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | Brunel Way Honeybourne WR11 7GJ Evesham 21 Worcestershire England | British | ||
LYNCH KNOLL WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
SOMERTON WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
NEXT GENERATION WIND HOLDINGS LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
ECOTECH WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British | ||
MERCHANT WIND PARK (EAST KILBRIDE) LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Rowcroft GL5 3BY Stroud Lion House England | British | ||
GREEN PARK WIND PARK LIMITED | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British | ||
SHOOTERS BOTTOM WIND PARK LTD | 14 nov. 2003 | 22 janv. 2018 | Active | Secrétaire | Beaumont House 172 Southgate Street GL1 2EZ Gloucester Gloucestershire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0