Ian David Nelson TURNBULL
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Ian |
| Deuxième prénom | David Nelson |
| Nom de famille | TURNBULL |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 2 |
| Démissionné | 17 |
| Total | 19 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILLESPIE MACANDREW FINANCIAL SERVICES LIMITED | 30 avr. 2007 | Dissoute | Administrateur | 38 Wilton Road EH16 5NN Edinburgh | Scotland | British | ||
| RUSSELL CORP. UK LIMITED | 05 juil. 1997 | Dissoute | Administrateur | 38 Wilton Road EH16 5NN Edinburgh | Scotland | British | ||
| CHEST HEART & STROKE SCOTLAND LTD | 28 nov. 2019 | 20 nov. 2025 | Active | Administrateur | 80 Hanover Street EH2 1EL Edinburgh Second Floor, Hobart House Scotland | Scotland | British | |
| GLASGOW DOG AND CAT HOME | 22 août 2013 | 25 mai 2021 | Active | Administrateur | Kingseat Road Halbeath KY11 8RY Dunfermline Fife | Scotland | British | |
| BRAEHEAD ENTERPRISES LIMITED | 22 août 2013 | 25 mai 2021 | Active | Administrateur | Kingseat Road Halbeath KY11 8RY Dunfermline Fife | Scotland | British | |
| SCOTTISH SPCA PROPERTY TRUSTEE LTD | 22 août 2013 | 25 mai 2021 | Active | Administrateur | Kingseat Road Halbeath KY11 8RY Dunfermline Fife | Scotland | British | |
| SCOTTISH SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS | 23 août 2012 | 25 mai 2021 | Active | Administrateur | Halbeath KY11 8RY Dunfermline Kingseat Road Fife | Scotland | British | |
| ATHOLL NOMINEES LIMITED | 19 mars 2014 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ | Scotland | British | |
| GILLESPIE MACANDREW WS LIMITED | 19 mars 2014 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| GILLESPIE MACANDREW LLP | 20 oct. 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Membre désigné de la LLP | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | ||
| BENNETT & ROBERTSON (TRUSTEES) LIMITED | 14 oct. 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| GILLESPIE MACANDREW DIRECTORS LIMITED | 11 août 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED | 11 août 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| MENZIES DOUGAL (NOMINEES) LIMITED | 01 août 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| MENZIES DOUGAL (TRUSTEES) LIMITED | 01 août 2005 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| GILLESPIE MACANDREW (TRUSTEES) LIMITED | 18 sept. 2002 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| J C AND A STEUART (TRUSTEES) LIMITED | 23 oct. 2001 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| GILLESPIE, MACANDREW (NOMINEES) LIMITED | 08 sept. 1999 | 31 déc. 2018 | Active | Administrateur | 5 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8EJ Midlothian | Scotland | British | |
| THE LADY HAIG POPPY FACTORY LIMITED | 24 mars 1999 | 08 juin 1999 | Dissoute | Administrateur | 38 Wilton Road EH16 5NN Edinburgh | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0