Michael Edward JONES
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | Michael |
| Deuxième prénom | Edward |
| Nom de famille | JONES |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 1 |
| Inactif | 4 |
| Démissionné | 8 |
| Total | 13 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEJ TWO LIMITED | 11 nov. 2022 | Dissoute | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court England | England | British | ||
| MEJ ONE LIMITED | 13 nov. 2020 | Dissoute | Administrateur | SE11 5QU London 239-241 Kennington Lane United Kingdom | England | British | ||
| CREWE CHILDRENS COMMUNITY INTEREST COMPANY | 25 mars 2017 | Dissoute | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court Cheshire United Kingdom | England | British | ||
| CREWE MEDICAL SCHOOL LTD | 18 oct. 2016 | Dissoute | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court Cheshire United Kingdom | England | British | ||
| GLENYS UK LTD | 01 avr. 1999 | Active | Administrateur | SE11 5QU London 239-241 Kennington Lane United Kingdom | England | British | ||
| APOLLO BUCKINGHAM HEALTH SCIENCES CAMPUS LIMITED | 24 mars 2017 | 30 juin 2021 | Active | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court Cheshire United Kingdom | England | British | |
| CRYSTAL COMMODITY TRADING LIMITED | 22 oct. 2020 | 07 janv. 2021 | Dissoute | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court Cheshire United Kingdom | England | British | |
| UNIQUE CHILDRENS COMMUNITY INTEREST COMPANY | 08 avr. 2016 | 07 août 2020 | Dissoute | Administrateur | Newcastle Road Blakelow CW5 7TE Nantwich 4 Horseshoe Court Cheshire United Kingdom | England | British | |
| ENTERPRISE CHESHIRE AND WARRINGTON | 01 nov. 2013 | 25 févr. 2016 | Active | Administrateur | Gadbrook Business Centre Rudheath CW9 7TN Northwich Richmond House Cheshire England | United Kingdom | British | |
| ALDERLEY PARK HOLDINGS LIMITED | 27 mars 2014 | 01 févr. 2016 | Active | Administrateur | Lloyd Street North Manchester Science Park M15 6SE Manchester Kilburn House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| MANCHESTER SCIENCE PARTNERSHIPS LIMITED | 27 mars 2014 | 01 févr. 2016 | Active | Administrateur | Lloyd Street North Manchester Science Park M15 6SE Manchester Kilburn House United Kingdom | United Kingdom | British | |
| UTC CREWE | 19 juin 2014 | 20 juil. 2015 | Dissoute | Administrateur | Middlewich Road CW11 1HZ Sandbach Westfields Cheshire | United Kingdom | British | |
| GLENYS UK LTD | 01 avr. 1999 | 01 mai 1999 | Active | Secrétaire | 1 College Hill 2nd Floor Sanderson Knight EC4R 2RA London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0