John Stuart DEWAR
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | John |
Deuxième prénom | Stuart |
Nom de famille | DEWAR |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 13 |
Inactif | 12 |
Démissionné | 16 |
Total | 41 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JME LOGISTICS LIMITED | 17 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire | British | |||
JME AT HOME LIMITED | 17 déc. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | |||
JAMIE MAGAZINE LIMITED | 03 nov. 2008 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
MADE WITH MAGIC LIMITED | 16 juil. 2008 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
RECIPEASE LIMITED | 07 déc. 2007 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
JME GROUP LIMITED | 08 nov. 2007 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
JAMIE'S MINISTRY OF FOOD LIMITED | 22 oct. 2007 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
SWEET AS CANDY (HOLDINGS) LIMITED | 04 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | |||
SWEET AS CANDY LIMITED | 02 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | |||
FRESH VENTURES (HOLDINGS) LIMITED | 01 sept. 2007 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
JAMIE OLIVER ENTERPRISES LIMITED | 01 sept. 2007 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
JAMIE OLIVER LICENSING LIMITED | 01 sept. 2007 | Active | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
FRESH NOMINEES LIMITED | 01 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | |||
FRESH SPACES LIMITED | 17 août 2007 | Dissoute | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | |||
FRESH DEVELOPMENTS LIMITED | 05 oct. 2004 | Dissoute | Co Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
JAMIE OLIVER PRODUCTIONS LIMITED | 01 août 2004 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
JOOLS ENTERPRISES LIMITED | 01 août 2004 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
JAMIE OLIVER LIMITED | 01 août 2004 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
FRESH CRUSH LIMITED | 01 août 2004 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
JAMIE OLIVER HOLDINGS LIMITED | 01 août 2004 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 15-21 Benwell Road N7 7BL London Benwell House England | British | ||
SWEET ENTERPRISES LIMITED | 01 août 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
FRESH RESIDENTIAL LIMITED | 01 août 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
THE FLOUR STATION (2) LIMITED | 01 août 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire | British | ||
FRESH MERCHANDISE LIMITED | 01 août 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
FRESH CUT DIGITAL LIMITED | 01 août 2004 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire | British | ||
THE PLANT CREATIVE LIMITED | 04 mai 2004 | 02 oct. 2019 | Active | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire | British | ||
THE FLOUR STATION LIMITED | 27 juin 2007 | 09 juil. 2015 | Dissoute | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | ||
FRESH PARTNERS LIMITED | 01 août 2004 | 16 déc. 2014 | Active | Company Secretary | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | |
JAMIE'S ITALIAN INTERNATIONAL LIMITED | 03 nov. 2008 | 19 juil. 2013 | Active | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | ||
BARBY LIMITED | 17 avr. 2008 | 19 juil. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | ||
JAMIE'S ITALIAN LIMITED | 01 sept. 2007 | 17 juil. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Wickhams Wharf, Viaduct Road SG12 9PT Ware 42 Hertfordshire United Kingdom | British | ||
FIFTEEN VENTURES LIMITED | 23 mars 2006 | 16 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
FIFTEEN RESTAURANT LIMITED | 01 août 2004 | 16 avr. 2008 | Dissoute | Company Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | |
JAMIE OLIVER FOOD FOUNDATION | 01 juil. 2003 | 16 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British | ||
JASPER THE PIG LIMITED | 23 avr. 2004 | 01 avr. 2008 | Active | Co Secretary | Secrétaire | 20 New Road Broomfield CM1 7AN Chelmsford Essex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0