BONDLAW SECRETARIES LIMITED
Dirigeant de société
Nom | BONDLAW SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 21 |
Démissionné | 140 |
Total | 161 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
NOBLE ENERGY SL LIMITED | 22 févr. 2018 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 United Kingdom | |
SNS (E&P) LIMITED | 01 juil. 2015 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 United Kingdom | |
DPS SUBSEA TECHNOLOGIES LIMITED | 28 janv. 2014 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
SONAR EQUIPMENT SERVICES LIMITED | 28 janv. 2014 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
DREELAN INVESTMENTS LIMITED | 15 janv. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Oceana House England | |
BOND PEARCE (RESOURCES) | 30 avr. 2010 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
MOLECULAR DEVICES (NEW MILTON) LTD | 15 mars 2010 | Dissoute | Secrétaire | Commercial Road SO15 1GA Southampton 39-49 Hampshire | |
GENETIX GROUP LIMITED | 15 mars 2010 | Dissoute | Secrétaire | Commercial Road SO15 1GA Southampton 39-49 Hampshire | |
LEICA MICROSYSTEMS (GATESHEAD) LTD | 15 mars 2010 | Dissoute | Secrétaire | Commercial Road SO15 1GA Southampton 39-49 Hampshire | |
ARJO WIGGINS US HOLDINGS | 24 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
ARJO WIGGINS NORTH AMERICA INVESTMENTS | 24 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
ARJO WIGGINS EUROPE HOLDINGS | 24 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
ARJO WIGGINS APPLETON HOLDINGS | 24 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England | |
AWA FINANCE | 24 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
CARTUS RELOCATION LIMITED | 25 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
PROFESSIONAL CONSULTANCY LIMITED | 14 oct. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
BUSINESS CHALLENGE SOUTH WEST | 14 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Commercial Road SO15 1GA Southampton 39-49 Hampshire | |
THE PEMBROKE COMMUNITY TRUST | 09 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire | 22 Kings Park Road SO15 2UF Southampton Hampshire | |
HEPHERD WINSTANLEY & PUGH LIMITED | 05 oct. 1999 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
BONDLAW DIRECTORS LIMITED | 11 sept. 1992 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
BOND PEARCE 2005 LIMITED | 10 nov. 1991 | Dissoute | Secrétaire | Oceana House 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | |
DELAMITE LIMITED | 12 mai 2000 | 16 nov. 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
ATLANTIS OFFSHORE LIMITED | 16 avr. 2014 | 30 sept. 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
BONDLAW NOMINEES LIMITED | 18 oct. 1992 | 22 sept. 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
BONDLAW NOMINEES (NO.2) LIMITED | 10 sept. 1992 | 22 sept. 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
DEVON SOCIAL FINANCE LIMITED | 09 juin 2017 | 06 juin 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 United Kingdom |
DEVON COMMUNITY FOUNDATION | 20 janv. 2000 | 01 juin 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
FASTNET ESTATES LIMITED | 09 mai 2004 | 30 mai 2022 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
LAMOR CORPORATION UK LIMITED | 29 mai 2003 | 25 mai 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
SOUTH WEST WATER SERVICES LIMITED | 01 mai 1998 | 31 mars 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
PENNON LIMITED | 02 janv. 1991 | 31 mars 2022 | Active | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
GROSVENOR WASTE MANAGEMENT LIMITED | 18 nov. 2010 | 31 mars 2022 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
ANGLIA RECYCLING LIMITED | 17 nov. 2010 | 31 mars 2022 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
ALIBONE RECYCLING LIMITED | 17 nov. 2010 | 31 mars 2022 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
OAKLEY WASTE MANAGEMENT LIMITED | 17 nov. 2010 | 31 mars 2022 | Dissoute | Secrétaire | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0